Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 12 tarjetas
23/10/2018 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-422645

Cambio de denominación social — 23/10/2018

Cambio de denominación social. AXA EXCLUSIV AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA SA. Datos registrales. T 32912 , F 157, S 8, H M 217178, I/A 134 (16.10.18).

29/08/2018 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-355056

Reelecciones — 29/08/2018

Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32912 , F 156, S 8, H M 217178, I/A 133 (21.08.18).

30/07/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-314847

Nombramientos — 30/07/2018

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ DELGADO MARIA DEL MAR;RUBIO TEJEDOR SILVIA;FRAGUAS CASTELLANOS ZULEMA;GUTIERREZ CASTEJON MARIA SOLEDAD;SOMOZA GARCIA FERNANDO;MESTRE GARCIA JORGE. Datos registrales. T 32912 , F 156, S 8...

27/07/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-313204

Ceses/dimisiones — 27/07/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: POLO GUTIERREZ CARMEN. Datos registrales. T 32912 , F 155, S 8, H M 217178, I/A 131 (20.07.18).

19/01/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-29478

Ceses/dimisiones — 19/01/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ PARIS NURIA. Nombramientos. Consejero: CARMONA JESUS. Con.Delegado: SAEZ DE JAUREGUI SANZ LUIS MARIA. Vicepresid.: CARMONA JESUS. Datos registrales. T 32912 , F 155, S 8, H M 21717...

13/10/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-404410

Ceses/dimisiones — 13/10/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: GALVEZ JIMENEZ FERNANDO. Vicepresid.: GALVEZ JIMENEZ FERNANDO. Con.Delegado: GALVEZ JIMENEZ FERNANDO. Datos registrales. T 32912 , F 155, S 8, H M 217178, I/A 129 ( 5.10.17).

25/09/2017 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-382054

Reelecciones — 25/09/2017

Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 32912 , F 154, S 8, H M 217178, I/A 128 (18.09.17).

12/07/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-286955

Nombramientos — 12/07/2017

Nombramientos. Apoderado: SAEZ DE JAUREGUI SANZ LUIS MARIA;NAVARRO GARCIA PEDRO ANTONIO;ROMERO PANIAGUA MARIA DEL MAR;LOPEZ GARCIA EUGENIO;ALZAGA VIZCARRA ALVARO;ALONSO ORDORICA SERGIO;JIMENEZ LOPEZ ANTONIO JAVIER;CARBO...

05/02/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-52470

Ceses/dimisiones — 05/02/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: PARICIO VILLEN JORGE. Vicepresid.: PARICIO VILLEN JORGE. Nombramientos. Consejero: CABALLERO TRIGO FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: CABALLERO TRIGO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 32912...

06/10/2015 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-401288

Fusión por absorción — 06/10/2015

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ASESORES DE SEGUROS ASEGUR AGENCIA DE SEGUROS SOCI. PUNTOS AZULES ASESORES DE SEGUROS SA DE AGENCIA DE. Datos registrales. T 25245 , F 59, S 8, H M 217178, I/A 119 (24.09.15).

02/08/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-347515

Ceses/dimisiones — 02/08/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAYA CASTILLO RAFAEL;PUZENAT FREDERIC. Nombramientos. Consejero: PARICIO VILLEN JORGE;LECLERCQ NICOLAS JOSEPH MICHEL. Reelecciones. Consejero: CASTRO GARRIDO JUAN MANUEL. Con.Delegado: CASTR...

01/07/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-279131

Nombramientos — 01/07/2011

Nombramientos. Apoderado: DE MAYLLI ALBAN;FLEJOU FREDERIC BRICE SEBASTIEN MARIE;DECKER ERICK JEAN CHARLES;CHOLVY LAURENT JULIEN;NARVAEZ LIONEL;PUZENAT FREDERIC;AMAT VILARO PAU;DOMENE MARTI MANEL;BERNUES ANAYA MARIA LORE...