Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2026 12 tarjetas
21/04/2026 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-192718

Nombramientos — 21/04/2026

Nombramientos. Apoderado: ROMAN DE LA SEN MARIA TERESA. Datos registrales. S 8 , H M 571711, I/A 21 (14.04.26).

11/12/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-508139

Revocaciones — 11/12/2019

Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ ANTON MARIA DEL CARMEN;FREIRE JIMENEZ INES;INVER SEIXAL INDUSTRIAL SL;FREIRE JIMENEZ LUCIA;FREIRE JIMENEZ ENRIQUE;YUSTE MORA MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 36282 , F 182, S 8, H...

14/08/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-356020

Nombramientos — 14/08/2019

Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ ANTON MARIA DEL CARMEN;FREIRE JIMENEZ INES;INVER SEIXAL INDUSTRIAL SL;FREIRE JIMENEZ LUCIA;FREIRE JIMENEZ ENRIQUE;ROMAN DE LA SEN MARIA TERESA;CARVAJAL MARTIN MARIA DE LOS ANGELES. Dato...

08/11/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-447245

Ceses/dimisiones — 08/11/2018

Ceses/Dimisiones. Secretario: FREIRE JIMENEZ ENRIQUE. Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ ANTON MARIA DEL CARMEN;FREIRE JIMENEZ INES;INVER SEIXAL INDUSTRIAL SL;FREIRE JIMENEZ LUCIA;FREIRE JIMENEZ ENRIQUE;YUSTE MORA MARIA D...

17/01/2018 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-24755

Fusión por absorción — 17/01/2018

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: ALJEZUR DE INVERSIONES SL. Datos registrales. T 36282 , F 169, S 8, H M 571711, I/A 14 ( 9.01.18).

25/09/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-381909

Revocaciones — 25/09/2017

Revocaciones. Apoderado: FREIRE ARTETA JOSE ENRIQUE;FREIRE JIMENEZ INES;GARCIA MARGALLO GOMENDIO VERONICA;FREIRE JIMENEZ LUCIA;FREIRE JIMENEZ ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ ANTON MARIA DEL CARMEN;FREIRE JIME...

25/08/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-348946

Ceses/dimisiones — 25/08/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: FREIRE ARTETA JOSE ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: JIMENEZ ANTON MARIA DEL CARMEN. Cambio de domicilio social. C/ SERRANO, 43-45, PISO 6, PUERTA 23. (MADRID). Datos registrales. T 32951 ,...

02/02/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-45038

Modificaciones estatutarias — 02/02/2016

Modificaciones estatutarias. 24. Administración y Representacion.- Retribución del cargo de administrador.. Datos registrales. T 32951 , F 72, S 8, H M 571711, I/A 11 (26.01.16).

15/01/2015 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-13712

Ampliación de capital — 15/01/2015

Ampliación de capital. Capital: 5.602.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.513.621,00 Euros. Otros conceptos: HA QUEDADO ADQUIRIDO EL PATRIMONIO SEGREGADO DE LA SOCIEDAD "INVER SEIXAL INDUSTRIAL, SL", HA QUEDADO AMPLIA...

04/08/2014 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-319675

Cambio de domicilio social — 04/08/2014

Cambio de domicilio social. C/ ZURBANO Nº45, 1º (MADRID). Datos registrales. T 31773 , F 117, S 8, H M 571711, I/A 5 (25.07.14).

18/02/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-76203

Nombramientos — 18/02/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREIRE JIMENEZ ENRIQUE;FREIRE JIMENEZ LUCIA. Apo.Manc.: FREIRE ARTETA ENRIQUE. Datos registrales. T 31773 , F 113, S 8, H M 571711, I/A 2 (10.02.14).

18/02/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-76204

Nombramientos — 18/02/2014

Nombramientos. Apoderado: GARCIA MARGALLO VERONICA. Datos registrales. T 31773 , F 115, S 8, H M 571711, I/A 3 (10.02.14).