Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 11 tarjetas
05/12/2014 Sec. I Disolución Zaragoza
Zaragoza-499047

Disolución — 05/12/2014

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46 C (28.11.14). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

17/11/2014 Sec. I Otros conceptos: CERRADA LA HOJA, por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil Zaragoza
Zaragoza-466560

Otros conceptos: cerrada la hoja, por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del reglamento del registro mercantil — 17/11/2014

Otros conceptos: CERRADA LA HOJA, por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46 F ( 6.11.14).

23/10/2013 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-454972

Revocaciones — 23/10/2013

Revocaciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 3314 , F 220, S 8, H Z 1465, I/A 46 (15.10.13)....

17/05/2013 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-226353

Revocaciones — 17/05/2013

Revocaciones. Apoderado: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Apo.Sol.: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 44 ( 8.05.13).

17/05/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-226354

Ceses/dimisiones — 17/05/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Con.Delegado: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Consejero: GRAF KLAUS. Presidente: GRAF KLAUS. Con.Delegado: GRAF KLAUS. Consejero: RECIO FERNANDEZ DIEGO. Nombramientos. Consej...

09/08/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-336451

Ceses/dimisiones — 09/08/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Secretario: DIAZ GUIJARRO ALBERTO. Nombramientos. Consejero: RECIO FERNANDEZ DIEGO. SecreNoConsj: FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8,...

12/06/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-248434

Revocaciones — 12/06/2012

Revocaciones. Apoderado: GARCIA ARIZA JESUS. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 42 (31.05.12).

22/09/2011 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-381833

Reelecciones — 22/09/2011

Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Datos registrales. T 3314 , F 219, S 8, H Z 1465, I/A 40 (12.09.11).

29/11/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-441528

Ceses/dimisiones — 29/11/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANZ ARRANZ MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Consejero: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Con.Delegado: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Reelecciones. Consejero: GRAF KLAUS. Presidente: GRAF KLAUS. Con.Delegado: G...

16/01/2009 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-24268

Nombramientos — 16/01/2009

Nombramientos. Apo.Sol.: BORQUE CESPEDES RAFAEL. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 36 ( 5.01.09).

07/01/2009 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-8346

Reelecciones — 07/01/2009

Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & CIA CENSORES JURADOS DE CUENTAS A. Datos registrales. T 3314 , F 218, S 8, H Z 1465, I/A 35 (23.12.08).