Actos destacados
Revocaciones — 22/01/2026
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. S 8 , H LE 10648, I/A 97 (15.01.26).
Reelecciones — 13/02/2019
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 975 , F 58, S 8, H LE 10648, I/A 90 ( 6.02.19).
Fe de erratas: rectificado el segundo apellido del secretario no consejero, que es torras y no torres, como en su día se publicó — 15/11/2018
Fe de erratas: Rectificado el segundo apellido del Secretario No Consejero, que es TORRAS y no Torres, como en su día se publicó. Datos registrales. T 975 , F 50, S 8, H LE 10648, I/A 76 (16.04.12).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 15/11/2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MELGAREJO GUIRADO GUSTAVO JAVIER. Datos registrales. T 975 , F 54, S 8, H LE 10648, I/A 81 b ( 8.11.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 219 Jueves 15 de...
Reelecciones — 15/11/2018
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH Mª;BARALLOBRE GORDON IGNACIO. Presidente: ANTONIUS ARETS JOSEPH Mª. Datos registrales. T 975 , F 57, S 8, H LE 10648, I/A 89 ( 8.11.18).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 18/11/2016
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 975 , F 57, S 8, H LE 10648, I/A 88 (11.11.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL...
Reelecciones — 26/01/2016
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&;BARALLOBRE GORDON IGNACIO. Presidente: ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Datos registrales. T 975 , F 57, S 8, H LE 10648, I/A 87 (20.01.16).
Revocaciones — 13/05/2015
Revocaciones. Apo.Manc.: KETTERLIN TIERRY;KETTERLIN TIERRY. Datos registrales. T 975 , F 57, S 8, H LE 10648, I/A 86 ( 6.05.15).
Reelecciones — 17/02/2015
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 975 , F 56, S 8, H LE 10648, I/A 85 (10.02.15).
Revocaciones — 04/02/2014
Revocaciones. Apo.Manc.: VRENCKEN ROGER;LUGOSI PETER JANOS;GUNTHER THOMAS. Nombramientos. Apo.Manc.: RODA GIORGIO;KETTERLIN TIERRY;HARTNEGG KAI;WINTERBERG PHILIPPE. Datos registrales. T 975 , F 56, S 8, H LE 10648, I/A...
Nombramientos — 09/01/2014
Nombramientos. Consejero: MELGAREJO GUIRADO GUSTAVO JAVIER. Datos registrales. T 975 , F 54, S 8, H LE 10648, I/A 81 ( 2.01.14).
Revocaciones — 09/01/2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MUDARRA PEDRO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&;BARALLOBRE GORDON IGNACIO. Apo.Manc.: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Apode...
Nombramientos — 09/01/2014
Nombramientos. Apoderado: ARETS JOSEPH MARIA ANTONIUS;BARALLOBRE GORDON IGNACIO;MARCOS VILLA EVA;MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;MELGAREJO GUIRADO GUSTAVO JAVIER. Datos registrales. T 975 , F 54, S 8, H LE 10648, I/A 82...
Ceses/dimisiones — 11/10/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERGES ARA EDUARDO. Presidente: BERGES ARA EDUARDO. Nombramientos. Consejero: BARALLOBRE GORDON IGNACIO. Presidente: ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Datos registrales. T 975 , F 52, S 8, H LE 1064...
Revocaciones — 11/10/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BERGES ARA EDUARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARALLOBRE GORDON IGNACIO. Apo.Manc.: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Apoderado: ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Datos regi...
Revocaciones — 24/05/2012
Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 975 , F 52, S 8, H LE 10648, I/A 78 (15.05.12).
Ceses/dimisiones — 25/04/2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BERGES ARA EDUARDO. Nombramientos. Consejero: BERGES ARA EDUARDO. Presidente: BERGES ARA EDUARDO. Consejero: MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. SecreNoConsj: VOLTA TOR...
Nombramientos — 25/04/2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERGES ARA EDUARDO;MARTINEZ MUDARRA PEDRO-ALBERTO;ANTONIUS ARETS JOSEPH M&. Datos registrales. T 975 , F 51, S 8, H LE 10648, I/A 77 (16.04.12).
Nombramientos — 18/10/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: KETTERLIN TIERRY;HARTNEGG KAI;WINTERBERG PHILIPPE;GUNTHER THOMAS. Datos registrales. T 975 , F 50, S 8, H LE 10648, I/A 75 ( 6.10.11).
Nombramientos — 08/08/2011
Nombramientos. Apo.Manc.: VRENCKEN ROGER;LUGOSI PETER JANOS. Datos registrales. T 975 , F 50, S 8, H LE 10648, I/A 74 (28.07.11).
Reelecciones — 05/08/2011
Reelecciones. Consejero: PIZZOCARO FRANCESCO. Presidente: PIZZOCARO FRANCESCO. Consejero: TUBERTINI PAOLO;PIZZOCARO CARLO. Con.Delegado: TUBERTINI PAOLO. SecreNoConsj: PERELLO TERUEL JOSE-MARIA. Datos registrales. T 975...
Ceses/dimisiones — 05/08/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PIZZOCARO FRANCESCO. Presidente: PIZZOCARO FRANCESCO. Consejero: TUBERTINI PAOLO;PIZZOCARO CARLO. Con.Delegado: TUBERTINI PAOLO. SecreNoConsj: PERELLO TERUEL JOSE-MARIA. Nombramientos. Adm....
Sociedad unipersonal — 05/08/2011
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DSM GROUP SPAIN 2000 SL. Datos registrales. T 975 , F 49, S 8, H LE 10648, I/A 71 (27.07.11).
Revocaciones — 05/08/2011
Revocaciones. Apoderado: PIZZOCARO ROBERTA;VENTURINI ROBERTO DANTE;PIZZOCARO FRANCESCO. Apo.Sol.: PIZZOCARO FRANCESCO;PIZZOCARO CARLO;FOFFANO PIERGIORGIO. Apoderado: SARTORATO MAURIZIO. Datos registrales. T 975 , F 49,...