Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 7 tarjetas
02/12/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-489714

Revocaciones — 02/12/2016

Revocaciones. Apoderado: DIAZ CRUZ RAFAEL. Datos registrales. T 33298 , F 176, S 8, H M 78395, I/A 64 (23.11.16).

17/11/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-465262

Nombramientos — 17/11/2016

Nombramientos. Apoderado: CALDERON DELGADO FRANCISCO. Datos registrales. T 33298 , F 176, S 8, H M 78395, I/A 63 (10.11.16).

14/03/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-125862

Nombramientos — 14/03/2013

Nombramientos. Apoderado: MARIN RUIZ JOSE CARLOS;FERRERAS SANCHEZ MANUEL ROBERTO. Datos registrales. T 4773 , F 223, S 8, H M 78395, I/A 57 ( 6.03.13).

07/08/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-331064

Nombramientos — 07/08/2012

Nombramientos. Apoderado: QUESADA ARRIAZA DOMINGO. Datos registrales. T 4773 , F 222, S 8, H M 78395, I/A 55 (25.07.12).

21/06/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-264387

Ceses/dimisiones — 21/06/2011

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: BENATOV BJORNULF BOUNATIAN. Consejero: BENATOV BJORNULF BOUNATIAN. Datos registrales. T 4773 , F 222, S 8, H M 78395, I/A 53 ( 9.06.11).

21/06/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-264388

Nombramientos — 21/06/2011

Nombramientos. Cons.Del.Sol: VEGA CALLEJA JOSEFINA. Datos registrales. T 4773 , F 222, S 8, H M 78395, I/A 54 ( 9.06.11).

09/02/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-68893

Nombramientos — 09/02/2009

Nombramientos. Apoderado: APARICI MARTIN FELIX. Datos registrales. T 4773 , F 220, S 8, H M 78395, I/A 51 (28.01.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 26 Lunes 9 de febrero de 2009 Pág. 8104 cve: BORME-A-2009...