Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 11 tarjetas
04/08/2016 Sec. I Declaración de unipersonalidad Madrid
Madrid-323411

Declaración de unipersonalidad — 04/08/2016

Declaración de unipersonalidad. Socio único: BURGER KING SPAIN SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PISANI FRANCISCO MARCELO. Nombramientos. Adm. Unico: JIMENEZ BLAZQUEZ GREGORIO. Datos registrales. T 32165 , F 129, S 8, H...

04/08/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-323412

Nombramientos — 04/08/2016

Nombramientos. Apoderado: CHACON RESINO IRENE. Datos registrales. T 32165 , F 129, S 8, H M 290368, I/A 68 (27.07.16).

04/08/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-323413

Nombramientos — 04/08/2016

Nombramientos. Apoderado: MACIAS PRESA NATALIA. Datos registrales. T 32165 , F 130, S 8, H M 290368, I/A 69 (27.07.16).

18/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-126931

Revocaciones — 18/03/2016

Revocaciones. Apoderado: REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA. Datos registrales. T 32165 , F 129, S 8, H M BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 54 Viernes 18 de marzo de 2016 Pág. 13521 cve: BORME-A-2016-54-...

29/12/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-530377

Nombramientos — 29/12/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: COLINO GIL EMILINA;FONSECA BLASCO ANGEL;LOPEZ MENENDEZ MARIA JOSE. Datos BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 247 Lunes 29 de diciembre de 2014 Pág. 57290 cve: BORME-A-2014-247-28 registr...

28/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-181985

Nombramientos — 28/04/2014

Nombramientos. Apoderado: REPSOL TESORERIA Y GESTION FINANCIERA SA. Datos registrales. T 27282 , F 208, S 8, H M 290368, I/A 56 (16.04.14).

20/12/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-544794

Revocaciones — 20/12/2013

Revocaciones. Apoderado: TOJAR MONSALVE JOSE LUIS. Apo.Sol.: GARCIA MARTINEZ RUBEN;ALBA SANTAMARIA MARIA. Apoderado: GUTIERREZ CAMARA ROCIO;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO. Datos registrales. T 27282 , F 208, S 8, H M 290368,...

01/02/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-50799

Nombramientos — 01/02/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: MANTEL QUINTEROS MARIA PATRICIA. Datos registrales. T 27282 , F 206, S 8, H M 290368, I/A 47 (22.01.13).

01/02/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-50800

Nombramientos — 01/02/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: MESEGUER CALAS SUSANA;FORWOOD WALTER CRISTIAN. Datos registrales. T 27282 , F 207, S 8, H M 290368, I/A 48 (22.01.13).

01/02/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-50801

Nombramientos — 01/02/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: QUIROGA VAZQUEZ DOLORES;SANCHEZ NAVARRO RAQUEL;TOJAR MONSALVE JOSE LUIS;GARCIA MARTINEZ RUBEN;ALBA SANTAMARIA MARIA;BENITO ZAMARRIEGO MARIANO;GUTIERREZ CAMARA ROCIO;DIAZ FERNANDEZ JOSE-MANUEL. D...

14/11/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-465588

Revocaciones — 14/11/2012

Revocaciones. Apoderado: BRAVO BALMORI JOSE MARIA;REDONDO LUQUE JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27282 , F 205, S 8, H M 290368, I/A 45 (29.10.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 218 Miércoles 14 de noviem...