Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
11/10/2019 Sec. I Cambio de denominación social Barcelona
Barcelona-422897

Cambio de denominación social — 11/10/2019

Cambio de denominación social. LACELIER SPAIN S.A. Datos registrales. T 42924 , F 136, S 8, H B 82283, I/A 61 ( 7.10.19).

17/07/2019 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-306863

Revocaciones — 17/07/2019

Revocaciones. APODERAD.SOL: FREDERIC ALAIN COSSAIS. Datos registrales. T 42924 , F 136, S 8, H B 82283, I/A 60 ( 9.07.19).

08/11/2018 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-446776

Revocaciones — 08/11/2018

Revocaciones. APODERAD.SOL: MARC MICHAEL PIERRE CONSTANTINI. Datos registrales. T 42924 , F 136, S 8, H B 82283, I/A 59 (30.10.18).

05/06/2018 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-235771

Nombramientos — 05/06/2018

Nombramientos. APODERAD.SOL: MARIE CHANTAL BERNADETTE MILLET;MARC MICHAEL PIERRE CONSTANTINI. Datos registrales. T 42924 , F 135, S 8, H B 82283, I/A 56 (29.05.18).

31/05/2018 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-229414

Revocaciones — 31/05/2018

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MIGUEL ANGEL SANTORO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: PHILIPPE JEAN ALAIN NATRELLA. Datos registrales. T 42924 , F 135, S 8, H B 82283, I/A 55 (23.05.18).

21/03/2018 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-129845

Nombramientos — 21/03/2018

Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: JEROME JEAN CHARLES BULTE. Datos registrales. T 42924 , F 135, S 8, H B 82283, I/A 54 (14.03.18).

21/02/2018 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-83731

Revocaciones — 21/02/2018

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JOELLE PELLEGRIN. Datos registrales. T 42924 , F 134, S 8, H B 82283, I/A 53 (14.02.18).

21/06/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-260316

Revocaciones — 21/06/2016

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CAMPS PAPIOL FERNANDO. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MIGUEL ANGEL SANTORO. Datos registrales. T 42924 , F 133, S 8, H B 82283, I/A 51 (14.06.16).

26/05/2016 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-223486

Nombramientos — 26/05/2016

Nombramientos. APODERAD.SOL: PHILIPPE JEAN ALAIN NATRELLA. Datos registrales. T 42924 , F 133, S 8, H B 82283, I/A 50 (13.05.16).

08/03/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-107045

Revocaciones — 08/03/2016

Revocaciones. APODERADO: CAMPS PAPIOL FERNANDO. Datos registrales. T 42924 , F 133, S 8, H B 82283, I/A 49 (26.02.16).

25/06/2014 Sec. I Reducción de capital Barcelona
Barcelona-261918

Reducción de capital — 25/06/2014

Reducción de capital. Importe reducción: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 42924 , F 132, S 8, H B 82283, I/A 46 (16.06.14).

11/11/2013 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-478873

Revocaciones — 11/11/2013

Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: GEORGE WILLIAM NEWTON;JEFFREY CHARLES KUSTER. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: NICOLAS JEAN LAURENT TORLOTING;CAMPS PAPIOL FERNANDO. Datos registrales. T 42924 , F 131, S 8, H B 82283, I/A 44 ( 4...

04/12/2012 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-499299

Nombramientos — 04/12/2012

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42924 , F 131, S 8, H B 82283, I/A 43 (26.11.12).