Actos destacados
Disolución — 13/05/2015
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 417 , F 201, S 8, H LU 5102, I/A A ( 5.05.15).
Reelecciones — 20/03/2015
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 417 , F 201, S 8, H LU 5102, I/A 42 (11.03.15).
Ceses/dimisiones — 16/09/2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TREMBLAIS SEBASTIEN PAUL LOIC. Nombramientos. Consejero: BORG CAROLINE. Presidente: BORG CAROLINE. Consejero: MARCENARO BARBARA. Secretario: MARCENARO BARBARA. Consejero: HENRIKSEN JOHNNY H...
Nombramientos — 03/03/2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCENARO BARBARA;LOPEZ DOLADO JUAN CARLOS;OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS;MOLINERO CANAL CARLOS. Datos registrales. T 412 , F 39, S 8, H LU 5102, I/A 37 (20.02.14).
Revocaciones — 03/03/2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCENARO BARBARA;LOPEZ DOLADO JUAN CARLOS;OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS;MOLINERO CANAL CARLOS. Datos registrales. T 412 , F 41, S 8, H LU 5102, I/A 38 (20.02.14).
Nombramientos — 25/06/2013
Nombramientos. Apoderado: PETRIE PACHECO PABLO. Datos registrales. T 412 , F 39, S 8, H LU 5102, I/A 36 (15.06.13).
Nombramientos — 21/06/2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCENARO BARBARA;LOPEZ DOBLADO JUAN CARLOS;OLABUENAGA BURON ANGEL LUIS. Datos registrales. T 369 , F 209, S 8, H LU 5102, I/A 34 (11.06.13).
Revocaciones — 21/06/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRIETO GONZALEZ NATALIA. Datos registrales. T 369 , F 209, S 8, H LU 5102, I/A 35 (11.06.13).
Sociedad unipersonal — 22/02/2013
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: VESTAS MANUFACTURING A/S. Ceses/Dimisiones. Consejero: MAGNUS BJORKMAN JAN;LOMHOLT HUSTED SOREN. Presidente: LOMHOLT HUSTED SOREN. Consejero: TREMBLAIS SEBASTIE...
Otros conceptos: modificacion de condiciones de concesion de incentivos regionales — 22/12/2011
Otros conceptos: MODIFICACION DE CONDICIONES DE CONCESION DE INCENTIVOS REGIONALES. Datos registrales. T 417 , F 201, S 8, H LU 5102, I/A NM ( 9.12.11).
Ceses/dimisiones — 26/10/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: BODENLLE LOPEZ LUIS. Secretario: BODENLLE LOPEZ LUIS. Con.Delegado: BODENLLE LOPEZ LUIS. Revocaciones. Apo.Man.Soli: BODENLLE LOPEZ LUIS. Nombramientos. Consejero: TREMBLAIS SEBASTIEN PAUL L...
Nombramientos — 24/10/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: ROCA MOURIN DIEGO;FINER JENS AXEL. Datos registrales. T 345 , F 168, S 8, H LU 5102, I/A 32 (11.10.11).
Reelecciones — 24/02/2011
Reelecciones. Consejero: LOMHOLT HUSTED SOREN. Presidente: LOMHOLT HUSTED SOREN. Consejero: BODENLLE LOPEZ LUIS. Secretario: BODENLLE LOPEZ LUIS. Con.Delegado: BODENLLE LOPEZ LUIS. Datos registrales. T 345 , F 168, S 8,...
Ceses/dimisiones — 09/02/2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL;KPGM AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHAUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 345 , F 168, S 8, H LU 5102, I/A 29 1 (27.01.11). http://www.boe.es BOLET...
Ceses/dimisiones — 11/12/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: KAMSTRUP KRISTENSEN POUL ERIK. Nombramientos. Consejero: MAGNUS BJORKMAN JAN. Datos registrales. T 345 , F 167, S 8, H LU 5102, I/A 27 (26.11.09).
Otros conceptos: cambio de denominación del socio único — 11/12/2009
Otros conceptos: Cambio de denominación del socio único. Datos registrales. T 345 , F 167, S 8, H LU 5102, I/A 28 (26.11.09).
Otros conceptos: concesión de incentivos regionales — 03/09/2009
Otros conceptos: Concesión de incentivos regionales. Datos registrales. T 369 , F 209, S 8, H LU 5102, I/A NM (18.08.09).
Declaración de unipersonalidad — 22/07/2009
Declaración de unipersonalidad. Socio único: VESTAS ASSEMBLY SA. Datos registrales. T 236 , F 182, S 8, H LU 5102, I/A 22 (12.05.05).
Nombramientos — 22/01/2009
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 345 , F 167, S 8, H LU 5102, I/A 26 ( 9.01.09). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958