Actos destacados
Nombramientos — 18/12/2019
Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA REMENTERIA IÑIGO. Datos registrales. T 38987 , F 151, S 8, H M 494460, I/A 54 (11.12.19).
Revocaciones — 19/07/2019
Revocaciones. Apoderado: PASQUIER PIERRE CHARLES HENRI. Nombramientos. Apoderado: FLORIO RAFFAELE. Datos registrales. T 33437 , F 224, S 8, H M 494460, I/A 53 (14.07.19).
Revocaciones — 12/06/2019
Revocaciones. Apoderado: WOLFF NICOLAS ANTOINE MARIE. Datos registrales. T 33437 , F 224, S 8, H M 494460, I/A 52 ( 5.06.19).
Revocaciones — 30/10/2018
Revocaciones. Apoderado: GRAZIANO MARCO;MARCENARO BARBARA;NORGAARD BRANDT HENRIK;WOLFF NICOLAS ANTOINE MARIE;RODRIGUEZ DIEZ JAVIER;GARCIA GRANDA ALEJANDRO;PLAZA MORAN ANGEL;JIMENO GUTIERREZ JOSE LUIS;PASQUIER PIERRE CHA...
Reelecciones — 26/04/2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33437 , F 220, S 8, H M 494460, I/A 48 (18.04.18).
Ceses/dimisiones — 15/01/2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BORG CAROLINE. Nombramientos. Adm. Mancom.: NORGAARD BRANDT HENRIK. Datos registrales. T 33437 , F 216, S 8, H M 494460, I/A 45 ( 4.01.18).
Ampliacion del objeto social — 15/01/2018
Ampliacion del objeto social. La gestión y administración de valores representativos de losfondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y...
Nombramientos — 15/01/2018
Nombramientos. Apoderado: GRAZIANO MARCO;MARCENARO BARBARA;NORGAARD BRANDT HENRIK;WOLFF NICOLAS ANTOINE MARIE;RODRIGUEZ DIEZ JAVIER;GARCIA GRANDA ALEJANDRO;PLAZA MORAN ANGEL;JIMENO GUTIERREZ JOSE LUIS;PASQUIER PIERRE CH...
Revocaciones — 27/12/2017
Revocaciones. Apoderado: ARALUCE Y MARTINEZ DE AZAGRA JUAN;KIRK JEPSEN THOMAS;GIL TEJERO JOSE MANUEL;RODRIGUEZ DIEZ JAVIER;SANCHEZ CASARES MARIA TERESA;MOLINERO CANAL CARLOS;GARCIA GRANDA ALEJANDRO. Apo.Sol.: ARALUCE Y...
Reelecciones — 18/06/2013
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 27436 , F 142, S 8, H M 494460, I/A 23 ( 7.06.13).
Revocaciones — 07/12/2012
Revocaciones. Apoderado: PACHECO PEREZ JESUS;CASTAÑERA SALOMON SANTIAGO. Apo.Man.Soli: NOVO CABRERA RAMON. Apoderado: LOPEZ DIAZ AGUSTIN. Datos registrales. T 27436 , F 136, S 8, H M 494460, I/A 20 (27.11.12).
Nombramientos — 07/12/2012
Nombramientos. Apoderado: MOLINERO CANAL CARLOS. Datos registrales. T 27436 , F 137, S 8, H M 494460, I/A 21 (27.11.12).
Declaración de unipersonalidad — 17/02/2010
Declaración de unipersonalidad. Socio único: VESTAS MEDITERRANEAN AS. Nombramientos. Apoderado: PICARDO TROYANO MIGUEL;ARALUCE Y MARTINEZ DE AZAGRA JUAN;JEPSEN THOMAS KIRK;GIL TEJERO JOSE MANUEL;PACHECO PEREZ JESUS;MORI...
Reducción de capital — 31/08/2009
Reducción de capital. Importe reducción: 500.001,95 Euros. Resultante Suscrito: 12.680.294,66 Euros. Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: VESTAS TOWERS MEDITERRANEAN SL. Datos registrales. T 40682...
Otros conceptos: constancia del cambio de denominacion del socio unico, que pasa a ser "vestas mediterranean a/s" — 26/06/2009
Otros conceptos: CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO, QUE PASA A SER "VESTAS MEDITERRANEAN A/S". Datos registrales. T 40682 , F 48, S 8, H B 149970, I/A 84 (12.06.09).