Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2010 4 tarjetas
08/03/2010 Sec. I Fusión por absorción A Coruña
A Coruña-97449

Fusión por absorción — 08/03/2010

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: VERTERRA GALICIA SL. Datos registrales. T 3120 , F 158, S 8, H C 39461, I/A 6 (25.02.10).

08/03/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-97450

Ceses/dimisiones — 08/03/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO;JAUREGUI PICABEA AITOR. Presidente: JAUREGUI PICABEA AITOR. Consejero: SEVILLA MARTINEZ JOSE MANUEL;SAINZ DE BARANDA Y CASADO SANTIAGO. Secretario: SAINZ DE BARA...

15/02/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-62858

Ceses/dimisiones — 15/02/2010

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: REINOSO TORRES FRANCISCO. Consejero: REINOSO TORRES FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: ARNAZ DUQUE ISRAEL. Datos registrales. T 3120 , F 158, S 8, H C 39461, I/A 5 ( 1.02.10).

24/09/2009 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-406909

Nombramientos — 24/09/2009

Nombramientos. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO. Cons.Del.Man: REINOSO TORRES FRANCISCO;JAUREGUI PICABEA AITOR;SEVILLA MARTINEZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3120 , F 158, S 8, H C 39461, I/A 4 (15.09.09).