Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 11 tarjetas
21/03/2017 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-126369

Cambio de denominación social — 21/03/2017

Cambio de denominación social. TRANSDEV DIVISION ESPAÑA SL. Cambio de domicilio social. C/ TORRELAGUNA 60 - 2ª PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 29861 , F 114, S 8, H M 537290, I/A 24 (10.03.17).

29/11/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-482615

Nombramientos — 29/11/2016

Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29861 , F 114, S 8, H M 537290, I/A 23 (21.11.16).

13/10/2016 Sec. I Ampliacion del objeto social Madrid
Madrid-412568

Ampliacion del objeto social — 13/10/2016

Ampliacion del objeto social. LA GESTION O EXPLOTACION, TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL EXTRANJERO, DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS. Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: TRANSDEV CAT...

30/08/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-359220

Ceses/dimisiones — 30/08/2016

Ceses/Dimisiones. Presidente: DUJARDIN RICHARD JACQUES. Consejero: DUJARDIN RICHARD JACQUES. Nombramientos. Consejero: BROSETA LAURENCE. Presidente: BROSETA LAURENCE. Datos registrales. T 29861 , F 107, S 8, H M 537290,...

30/08/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-359221

Nombramientos — 30/08/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BROSETA LAURENCE;JAFFARD PIERRE;STURZENEGGER JEAN;DA SILVA CARDOSO VITOR MANUEL;DE OLIVEIRA RAIMUNDO ARMENIO. Datos registrales. T 29861 , F 107, S 8, H M 537290, I/A 21 (16.08.16).

04/03/2016 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-104112

Cambio de domicilio social — 04/03/2016

Cambio de domicilio social. C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 4 (MADRID). Datos registrales. T 29861 , F 106, S 8, H M 537290, I/A 19 (25.02.16).

24/02/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-80861

Ceses/dimisiones — 24/02/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: BRUYANT FRANCOIS ANTOINE. Nombramientos. Consejero: JAFFARD PIERRE. Datos registrales. T 29861 , F 103, S 8, H M 537290, I/A 15 (17.02.15).

23/12/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-523724

Ceses/dimisiones — 23/12/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ RANGEL GUSTAVO ENRIQUE. Secretario: RODRIGUEZ RANGEL GUSTAVO ENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA MUÑOZ FAUSTINO JESUS. Datos registrales. T 29861 , F 100, S 8, H M BOLETÍN...

05/07/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-284441

Ceses/dimisiones — 05/07/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDE SAHUQUILLO MANEL. Presidente: VIDE SAHUQUILLO MANEL. Revocaciones. Apoderado: VIDE I SAHUQUILLO MANEL;MIROSLAV KINKOR GUY. Nombramientos. Consejero: DESCAMPS ALAIN GEORGES ALBERT. Presi...

05/07/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-284442

Nombramientos — 05/07/2012

Nombramientos. Apoderado: BAUS HELENE SANDRA NATHALIE;RAMOS CUETO PEDRO JOSE. Datos registrales. T 29861 , F 97, S 8, H M 537290, I/A 7 (26.06.12).

09/04/2012 Sec. I Revocaciones Navarra
Navarra-157526

Revocaciones — 09/04/2012

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ-VILANOVA MARTINEZ JOAQUIN;CID CALZADA LUIS. Nombramientos. Apoderado: MIROSLAV KINKOR GUY. Datos registrales. T 542 , F 213, S 8, H NA 11444, I/A 92 (23.03.12).