Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 19 tarjetas
20/06/2018 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-259696

Cambio de denominación social — 20/06/2018

Cambio de denominación social. SACYR SERVICIOS SA. Datos registrales. T 28383 , F 196, S 8, H M 311939, I/A 115 (13.06.18).

20/04/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-174783

Ceses/dimisiones — 20/04/2018

Ceses/Dimisiones. VsecrNoConsj: MANSO MARTINEZ DE BEDOYA GERARDO. Datos registrales. T 28383 , F 196, S 8, H M 311939, I/A 114 (13.04.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 77 Viernes 20 de abril de 2018 Pág....

16/04/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-166732

Nombramientos — 16/04/2018

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ ANGEL. Datos registrales. T 28383 , F 196, S 8, H M 311939, I/A 113 ( 9.04.18).

18/08/2017 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-340660

Modificaciones estatutarias — 18/08/2017

Modificaciones estatutarias. 5. Capital social . Refundición de estatutos sociales . Datos registrales. T 28383 , F 192, S 8, H M 311939, I/A 111 ( 9.08.17).

25/10/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-429188

Revocaciones — 25/10/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: MANSO MARTINEZ DE BEDOYA GERARDO. Datos registrales. T 28383 , F 190, S 8, H M 311939, I/A 106 (14.10.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 204 Martes 25 de octubre de 2016 Pág. 46495...

07/09/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-367901

Reelecciones — 07/09/2016

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28383 , F 190, S 8, H M 311939, I/A 105 (31.08.16).

09/08/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-328356

Reelecciones — 09/08/2016

Reelecciones. Consejero: LOZANO SAINZ FERNANDO. Con.Delegado: LOZANO SAINZ FERNANDO. Datos registrales. T 28383 , F 190, S 8, H M 311939, I/A 104 ( 1.08.16).

29/03/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-139204

Revocaciones — 29/03/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: PALOMO GOMEZ RAFAEL. Apoderado: PALOMO GOMEZ RAFAEL. Apo.Manc.: PALOMO GOMEZ RAFAEL. Datos registrales. T 28383 , F 190, S 8, H M 311939, I/A 103 (18.03.16).

10/12/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-500302

Revocaciones — 10/12/2015

Revocaciones. Apoderado: GARCIA SAN MIGUEL RODRIGUEZ-ALARCON GONZALO. Datos registrales. T 28383 , F 187, S 8, H M 311939, I/A 98 ( 1.12.15).

03/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-491387

Nombramientos — 03/12/2015

Nombramientos. Apoderado: MANJON MANJON TERESA;SEGURA FERNANDEZ ANDREA;RANZ AZCUTIA ELISA. Datos registrales. T 28383 , F 185, S 8, H M 311939, I/A 96 (25.11.15).

03/12/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-491388

Nombramientos — 03/12/2015

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GONZALEZ ANGEL;ARES GASTESI MARIA-ROSARIO;DE DIAGO FERRERA JAIME;GOMEZ BLANCO CESAR;LOZANO SAINZ FERNANDO;ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO;GUTIERREZ POZO LEONIDES;NUÑEZ-BARRANCO LOPEZ P...

30/06/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-268004

Revocaciones — 30/06/2015

Revocaciones. Apoderado: CALLEJA MATEO GONZALO. Datos registrales. T 28383 , F 184, S 8, H M 311939, I/A 93 (22.06.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 121 Martes 30 de junio de 2015 Pág. 28953 cve: BORME-A-...

12/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-107948

Ceses/dimisiones — 12/03/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARREDONDO DIAZ FRANCISCO JAVIER. Secretario: ARREDONDO DIAZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. SecreNoConsj: ARREDONDO DIAZ FRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. 17. Administración y...

30/04/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-186232

Revocaciones — 30/04/2014

Revocaciones. Apoderado: DE SAN JOSE TORIJA JORGE. Apo.Sol.: GALLARDO FERNANDEZ DIEZ ROBERTO. Datos registrales. T 28383 , F 182, S 8, H M 311939, I/A 89 (22.04.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 82 Miérco...

31/12/2013 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-559347

Reelecciones — 31/12/2013

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28383 , F 182, S 8, H M 311939, I/A 88 (23.12.13).

19/04/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-186799

Ceses/dimisiones — 19/04/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: TORREAL SA. Representan: DEL CORRO GARCIA-LOMAS PEDRO. Secretario: ARREDONDO DIAZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Consejero: ARREDONDO DIAZ FRANCISCO JAVIER. Secretario: ARREDONDO DIAZ FRAN...

01/12/2010 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-444579

Revocaciones — 01/12/2010

Revocaciones. Apo.Sol.: PINO GIRALDEZ MANUEL ALEJANDRO. Datos registrales. T 27247 , F 219, S 8, H M 311939, I/A 75 (22.11.10).

19/04/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-154632

Ceses/dimisiones — 19/04/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVES DINIZ VAZ GUEDES DIOGO. Datos registrales. T 27247 , F 217, S 8, H M 311939, I/A 70 ( 6.04.10).

27/07/2009 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-330860

Revocaciones — 27/07/2009

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ARIAS DE LUXAN JAVIER ANGEL;SIGUENZA HERNANDEZ PEDRO;ABRIL-MARTOREL HERNANDEZ PABLO;NUÑEZ-BARRANCO LOPEZ PEDRO. Apoderado: OTERO FERNANDEZ JOSE CARLOS;DIEZ GARCIA AZUCENA;FERNANDEZ REINA JAVI...