Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
22/04/2019 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-175193

Reelecciones — 22/04/2019

Reelecciones. Consejero: VARGAS ZUÑIGA CORSINI BORJA. Presidente: VARGAS ZUÑIGA CORSINI BORJA. Consejero: BALSARTO GESTION SOCIEDAD LIMITADA;ANTUÑA FERNANDEZ TERESA;CORSINI PEREZ JACOBO.Secretario: ANTUÑA FERNANDEZ TERE...

18/02/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-74182

Ceses/dimisiones — 18/02/2019

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ-VILLANUEVA GARCIA DE LA INFANTA JOSE. Secretario: ALVAREZ-VILLANUEVA GARCIA DE LA INFANTA JOSE. Nombramientos. Secretario: ANTUÑA FERNANDEZ TERESA. Datos registrales. T 36947 , F 39,...

06/02/2019 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-54385

Modificaciones estatutarias — 06/02/2019

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 18.-. Datos registrales. T 36947 , F 39, S 8, H M 272888, I/A 32 (28.01.19).

08/01/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-10036

Nombramientos — 08/01/2018

Nombramientos. Apoderado: MENCHEN DEL CERRO ROBERTO. Datos registrales. T 36947 , F 38, S 8, H M 272888, I/A 31 (29.12.17).

23/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-260477

Nombramientos — 23/06/2017

Nombramientos. Consejero: CORSINI PEREZ JACOBO. Reelecciones. Consejero: VARGAS ZUÑIGA CORSINI BORJA;ALVAREZ-VILLANUEVA GARCIA DE LA INFANTA JOSE. Presidente: VARGAS ZUÑIGA CORSINI BORJA. Secretario: ALVAREZ-VILLANUEVA...

29/09/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-393167

Nombramientos — 29/09/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SILVESTRE DEL VAL MIGUEL. Datos registrales. T 16281 , F 85, S 8, H M 272888, I/A 29 (21.09.16).

24/06/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-267597

Nombramientos — 24/06/2016

Nombramientos. Apoderado: VARGAS-ZUÑIGA CORSINI FRANCISCO BORJA;MARTIN MARTINEZ ANGEL. Datos registrales. T 16281 , F 83, S 8, H M 272888, I/A 28 (17.06.16).

13/08/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-337460

Cambio de domicilio social — 13/08/2015

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA HABANA 12 (MADRID). Datos registrales. T 16281 , F 36, S 8, H M 272888, I/A 25 ( 5.08.15).

13/07/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-285954

Ceses/dimisiones — 13/07/2015

Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DE HERRERA ORIA LUIS. Consejero: INMODESARROLLOS INTEGRADOS SL. Nombramientos. Representan: ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS FERNANDO. Consejero: BALSARTO GESTION SOCIEDAD LIMITADA;ANTUÑA FERN...

09/05/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-214337

Ceses/dimisiones — 09/05/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: TINACOR 2 SL. Representan: CORSINI MUÑOZ MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 16281 , F 34, S 8, H M 272888, I/A 18 (26.04.13).

02/04/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-152530

Ceses/dimisiones — 02/04/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARTACHO CORSINI VICTOR. Representan: ARTACHO CORSINI ALICIA. Nombramientos. Consejero: ARTACHO CORSINI ALICIA. Representan: ARTACHO CORSINI VICTOR. Datos registrales. T 16281 , F 33, S 8, H...

02/04/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-152531

Ceses/dimisiones — 02/04/2013

Ceses/Dimisiones. Presidente: LOURBACOR SL. Nombramientos. Presidente: ALCOR AMANDI SL. Datos registrales. T 16281 , F 33, S 8, H M 272888, I/A 16 (21.03.13).

02/04/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-152532

Nombramientos — 02/04/2013

Nombramientos. SecreNoConsj: NAVARRO ANGULO ANTONIO. Reelecciones. Consejero: ALCOR AMANDI SL;TINACOR 2 SL;CANTOS AZULES SL;LOURBACOR SL. Presidente: ALCOR AMANDI SL. Datos registrales. T 16281 , F 33, S 8, H M 272888,...