Actos destacados
Ceses/dimisiones — 04/11/2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS. Auditor: DELOITTE SL. Socio único: QUIRON HOSPITALES SL. Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ ALONSO JUAN JOSE;MONTERO CLAVERO FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli: MIL...
Ceses/dimisiones — 13/05/2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RUBIO LAPORTA JOSE RAMON;CORDON MURO MARIA ESTHER. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ ACEBES JUAN CARLOS. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradores...
Nombramientos — 13/05/2015
Nombramientos. Apo.Sol.: DELPON ORMAECHEA IGNACIO;KOCINA MALLO OSCAR. Datos registrales. T 2570 , F 10, S 8, H PM 56780, I/A 37 ( 6.05.15).
Modificaciones estatutarias — 12/05/2015
Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos registrales. T 2469 , F 209, S 8, H PM 56780, I/A 30 (25.09.12).
Nombramientos — 30/04/2014
Nombramientos. Apoderado: QUIRON HOSPITALES SL. Datos registrales. T 2469 , F 210, S 8, H PM 56780, I/A 35 (23.04.14).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 26/11/2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2469 , F 210, S 8, H PM 56780, I/A 34 (19.11.13).
Revocaciones — 16/07/2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE ZULUETA GREENEBAUM JOHN;DE ALVARO REGUERA FRANCISCO;VILLARINO MARZO MARIA DEL PILAR;TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO;BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES. Apo.Sol.: JUARROS ALCALDE MARIA JOSE. Datos reg...
Reelecciones — 07/02/2013
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2469 , F 210, S 8, H PM 56780, I/A 32 (30.01.13).
Modificaciones estatutarias — 16/11/2012
Modificaciones estatutarias. ARTICULO 9º.- DERECHOS REALES SOBRE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.- El usufructo y prenda de participaciones sociales seajustará a las normas legales. En caso de copropiedad los copropietario...
Ceses/dimisiones — 04/10/2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: USP HOSPITALES SL. Nombramientos. Adm. Solid.: CORDON MURO MARIA ESTHER;RUBIO LAPORTA JOSE RAMON. Datos registrales. T 2469 , F 209, S 8, H PM 56780, I/A 30 (25.09.12).
Revocaciones — 23/02/2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOSANTOS BONETA LUIS GERMAN;LEWIS GRAEME ROBERT. Datos registrales. T 2469 , F 209, S 8, H PM 56780, I/A 29 (13.02.12).
Reelecciones — 24/01/2012
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2469 , F 209, S 8, H PM 56780, I/A 28 (12.01.12).
Nombramientos — 17/11/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CANELO PINILLA CAYETANO. Datos registrales. T 2469 , F 208, S 8, H PM 56780, I/A 27 ( 4.11.11).
Nombramientos — 23/08/2011
Nombramientos. Apo.Sol.: JUARROS ALCALDE MARIA JOSE. Datos registrales. T 2447 , F 44, S 8, H PM 56780, I/A 26 (10.08.11).
Revocaciones — 12/07/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MATEOS GARCIA RICARDO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: LEWIS GRAEME ROBERT;TRUJILLO CASAS JUAN RICARDO;BARREIRO HERNANDEZ MERCEDES;USON JAEGER PATRICIA ELISABETH;RICO PEREZ PEDRO CANDIDO. Datos...
Reelecciones — 09/06/2011
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2447 , F 43, S 8, H PM 56780, I/A 24 (31.05.11).
Revocaciones — 17/02/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MONTERO CLAVERO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FUENTES NIETO CARLOS. Datos registrales. T 2447 , F 41, S 8, H PM 56780, I/A 23 ( 7.02.11).
Revocaciones — 03/02/2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CABRERA AYALA JOSE LUIS;JIMENEZ DE LAS HERAS GEMMA;BERRA DE UNAMUNO RAMON;MATEOS GARCIA RICARDO;GAMEZ SANCHEZ DANIEL;BERTRAN DAMIAN SERGIO;SERVERA GORNALS CATALINA. Nombramientos. Apo.Man.Sol...
Fe de erratas: se rectifica el nombre del representante de "usp hospitales sl", que es d — 27/01/2011
Fe de erratas: Se rectifica el nombre del representante de "USP Hospitales SL", que es D.Francisco de Alvaro Reguera y no D. Ramon Berra de Unamuno. Datos registrales. T 2358 , F 149, S 8, H PM 56780, I/A 20 (18.01.11).
Ceses/dimisiones — 04/08/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PRAT DOMENECH JOSE. Presidente: PRAT DOMENECH JOSE. Secretario: BERRA DE UNAMUNO RAMON. Nombramientos. Consejero: DE ALVARO REGUERA FRANCISCO. SecreNoConsj: MILLAN FERNANDEZ ISAAC. President...
Revocaciones — 15/07/2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL;ARIAS IRIGOYEN JUAN RAMON;JORGE NEBOT MARIA SOLEDAD;CALVO DEL MOLINO JUAN PEDRO;CURA BLASI MARIA ALBA;ELLAURI SANCHEZ PEDRO;SULTAN BENGUIGUI ESTHER;VINYALS CASADO...
Ceses/dimisiones — 04/06/2010
Ceses/Dimisiones. Presidente: MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL. Consejero: MASFURROLL LACAMBRA GABRIEL. Secretario: CALVO DEL MOLINO JUAN PEDRO. Consejero: CALVO DEL MOLINO JUAN PEDRO;JORGE NEBOT MARIA SOLEDAD;ARIAS IRIGOYEN...
Sociedad unipersonal — 04/06/2010
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: USP HOSPITALES SL. Datos registrales. T 2358 , F 148, S 8, H PM 56780, I/A 14 (19.05.10).
Nombramientos — 08/02/2010
Nombramientos. Apoderado: MONTERO CLAVERO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2358 , F 148, S 8, H PM 56780, I/A 12 (26.01.10).