Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 18 tarjetas
21/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-300669

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apo.Man.Soli: OLIVARES GOMEZ RAFAEL. Nombramientos. Apoderado: MATE DAROCA FERNANDO. Datos registrales. T 21970 , F 68, S 8, H M 50877, I/A 215 ( 9.07.15).

21/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-300670

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ OCHOA JAVIER. Datos registrales. T 21970 , F 69, S 8, H M 50877, I/A 216 ( 9.07.15).

21/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-300671

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apoderado: ALARCON ALEJANDRE JORGE;RONQUILLO ORTIZ MANUEL. Datos registrales. T 21970 , F 72, S 8, H M 50877, I/A 217 ( 9.07.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 136 Martes 21 de julio de 2015...

21/07/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-300672

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apo.Manc.: SANZ MARTIN JOSE LUIS. Datos registrales. T 21970 , F 73, S 8, H M 50877, I/A 218 ( 9.07.15).

07/05/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-186848

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARRASCOSA RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 21970 , F 68, S 8, H M 50877, I/A 214 (27.04.15).

11/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-162927

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SERRATOSA LUJAN GONZALO. Datos registrales. T 21970 , F 62, S 8, H M 50877, I/A 209 (31.03.14).

24/07/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-332634

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Revocaciones. Apoderado: ALONSO HUMAYOR JOSE ANTONIO;MARCOS CARTELLE CARMEN MINIA. Datos registrales. T 21970 , F 61, S 8, H M 50877, I/A 207 (16.07.13).

05/06/2012 Sec. I Reducción de capital Madrid
Madrid-237152

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Reducción de capital. Importe reducción: 17.296.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.350.000,00 Euros. Datos registrales. T 21970 , F 55, S 8, H M 50877, I/A 196 (24.05.12).

24/02/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-91778

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ PRIETO ALCAZAR JAVIER. Nombramientos. Consejero: DEL RIO NOVO CARMEN. Datos registrales. T 21970 , F 48, S 8, H M 50877, I/A 192 (15.02.12).

11/08/2011 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-335052

URALITA SISTEMAS DE TUBERIAS SOCIEDAD ANONIMA

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 21970 , F 47, S 8, H M 50877, I/A 190 (27.07.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 153 Jueves 11 de agosto de 2011 Pág. 41243 cve: BORME-A-2011-153-28

22/11/2010 Sec. I Revocaciones Ciudad Real
Ciudad Real-429963

Revocaciones — 22/11/2010

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ SOLANO ROMERO ALVARO. Nombramientos. Apoderado: DEL RIO NOVO CARMEN. Datos registrales. T 512 , F 132, S 8, H CR 20180, I/A 10 ( 2.11.10).

28/10/2010 Sec. I Nombramientos Ciudad Real
Ciudad Real-399200

Nombramientos — 28/10/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLASCO MARZAL FERNANDO. Datos registrales. T 512 , F 130, S 8, H CR 20180, I/A 6 ( 1.10.10).

28/10/2010 Sec. I Nombramientos Ciudad Real
Ciudad Real-399201

Nombramientos — 28/10/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERO GOZALO RAFAEL. Datos registrales. T 512 , F 131, S 8, H CR 20180, I/A 7 ( 1.10.10).

28/10/2010 Sec. I Revocaciones Ciudad Real
Ciudad Real-399202

Revocaciones — 28/10/2010

Revocaciones. Apoderado: RUBIO MORANO MANUEL;SENDRA BAYER JUAN. Datos registrales. T 512 , F 132, S 8, H CR 20180, I/A 8 ( 1.10.10).

13/09/2010 Sec. I Reelecciones Ciudad Real
Ciudad Real-348680

Reelecciones — 13/09/2010

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 512 , F 130, S 8, H CR 20180, I/A 5 (16.08.10).

20/08/2010 Sec. I Reelecciones Ciudad Real
Ciudad Real-326163

Reelecciones — 20/08/2010

Reelecciones. Consejero: SANCHEZ PRIETO ALCAZAR JAVIER;POZO PALOMARES JOSE LUIS;MARTINEZ CORRAL ALBERTO. Datos registrales. T 512 , F 130, S 8, H CR 20180, I/A 4 ( 2.08.10).

05/02/2010 Sec. I Revocaciones Ciudad Real
Ciudad Real-48590

Revocaciones — 05/02/2010

Revocaciones. Apoderado: CERDAN ALENDA JOSE;RODRIGUEZ GALA JAVIER;VERDU LAZARO JUAN. Datos registrales. T 512 , F 130, S 8, H CR 20180, I/A 3 (27.01.10).

21/01/2010 Sec. I Cambio de domicilio social Ciudad Real
Ciudad Real-22955

Cambio de domicilio social — 21/01/2010

Cambio de domicilio social. AVDA DE LOS VINOS, 24 - POLIGONO INDUSTRIAL ALCES (ALCAZAR DE SAN JUAN). Datos registrales. T 512 , F 129, S 8, H CR 20180, I/A 2 (17.12.09).