Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 21 tarjetas
07/11/2013 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-475289

Sociedad unipersonal — 07/11/2013

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: UNIBAIL RODAMCO SE. Datos registrales. T 31340 , F 133, S 8, H M 12652, I/A 219 (29.10.13).

07/10/2013 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-428587

Fusión por absorción — 07/10/2013

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: UNIBAIL RODAMCO PROYECTO BADAJOZ SL. Datos registrales. T 29531 , F 203, S 8, H M 12652, I/A 217 (27.09.13).

07/06/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-262115

Ceses/dimisiones — 07/06/2013

Ceses/Dimisiones. Consejero: CUVILLIER CHRISTOPHE. Secretario: CUVILLIER CHRISTOPHE. Nombramientos. Consejero: TRITANT JEAN MARIE ROBERT. Secretario: TRITANT JEAN MARIE ROBERT. Datos registrales. T 29531 , F 199, S 8, H...

20/03/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-132504

Revocaciones — 20/03/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: IBAÑEZ GABILONDO MANUEL;CORELL GASCO VICENTE;FERRACCI LAETITIA. Apoderado: MARTINEZ DE SALAZAR SEPULVEDA MARIA AUXILIADORA. Apo.Sol.: VALERO SEGOVIA OSCAR. Apoderado: MIRANDA DE PABLO MARIA;SEMEL...

20/03/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-132505

Revocaciones — 20/03/2013

Revocaciones. Apoderado: TEVES CORWITH CATHERINE. Datos registrales. T 29531 , F 199, S 8, H M 12652, I/A 212 (11.03.13).

14/03/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-125816

Nombramientos — 14/03/2013

Nombramientos. Apoderado: GARCIA GUMIEL CRISTINA. Datos registrales. T 29531 , F 198, S 8, H M 12652, I/A 207 ( 6.03.13).

14/03/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-125817

Revocaciones — 14/03/2013

Revocaciones. Apo.Sol.: LATORRE RODRIGUEZ FERNANDO. Datos registrales. T 29531 , F 198, S 8, H M 12652, I/A 208 ( 6.03.13).

26/02/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-96525

Revocaciones — 26/02/2013

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ILLAN DE HARO ENRIQUE;CERNUDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;AOUSTIN MAEL. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ILLAN DE HARO ENRIQUE;SOLIS GARCIA JAVIER;AOUSTIN MAEL. Datos registrales. T 29531 , F 194,...

20/09/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-384465

Nombramientos — 20/09/2012

Nombramientos. Apo.Manc.: BAYON GAYO ENRIQUE. Datos registrales. T 28990 , F 44, S 8, H M 12652, I/A 199 (10.09.12).

22/05/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-215012

Nombramientos — 22/05/2012

Nombramientos. Apo.Sol.: PARTIDA LAFUENTE ALFREDO;LLAMAS MONTES ADRIAN;FERNANDEZ PARADELO MATILDE;GUERRERO CELESTEN PATRICIA. Datos registrales. T 28990 , F 44, S 8, H M 12652, I/A 197 ( 9.05.12).

29/12/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-521399

Revocaciones — 29/12/2011

Revocaciones. Apoderado: VICENTE VAZQUEZ EUGENIO JULIO. Nombramientos. Apoderado: BAYON GAYO ENRIQUE. Datos registrales. T 28990 , F 41, S 8, H M 12652, I/A 193 (19.12.11).

10/11/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-446280

Nombramientos — 10/11/2011

Nombramientos. Apoderado: TEVES CORWITH CATHERINE. Datos registrales. T 28990 , F 34, S 8, H M 12652, I/A 189 (27.10.11).

21/09/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-379363

Revocaciones — 21/09/2011

Revocaciones. Apoderado: FONTECHA ANDUJAR LUIS. Nombramientos. Apoderado: FONTECHA ANDUJAR LUIS. Datos registrales. T 28990 , F 33, S 8, H M 12652, I/A 187 ( 3.09.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 180 Mié...

16/03/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-119183

Revocaciones — 16/03/2011

Revocaciones. Apoderado: MORELLE STEPHANIE CELINE. Datos registrales. T 23151 , F 192, S 8, H M 12652, I/A 171 ( 7.03.11).

16/03/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-119184

Revocaciones — 16/03/2011

Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ GOMEZ JESUS ALBERTO. Datos registrales. T 23151 , F 192, S 8, H M 12652, I/A 172 ( 7.03.11).

16/03/2011 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-119185

Revocaciones — 16/03/2011

Revocaciones. Apo.Sol.: DOMECQ ARGUESO TOMAS. Datos registrales. T 23151 , F 192, S 8, H M 12652, I/A 173 ( 7.03.11).

23/12/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-473333

Ceses/dimisiones — 23/12/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: JESTIN JEAN-MARC. Presidente: JESTIN JEAN-MARC. Nombramientos. Consejero: TONCKENS JACOB LUNSINGH. Presidente: TONCKENS JACOB LUNSINGH. Datos registrales. T 23151 , F 191, S 8, H M 12652, I/...

31/08/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-336570

Nombramientos — 31/08/2010

Nombramientos. Apoderado: ORCHAD SIMON THOMAS. Datos registrales. T 23151 , F 188, S 8, H M 12652, I/A 162 (19.08.10).

31/08/2010 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-336571

Revocaciones — 31/08/2010

Revocaciones. Apoderado: IMAZ DE LAS ALAS-PUMARIÑO ANDRES. Datos registrales. T 23151 , F 189, S 8, H M 12652, I/A 163 (20.08.10).

31/08/2010 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-336572

Nombramientos — 31/08/2010

Nombramientos. Apoderado: FONTECHA ANDUJAR LUIS. Datos registrales. T 23151 , F 189, S 8, H M 12652, I/A 164 (20.08.10).

09/02/2009 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-68957

Revocaciones — 09/02/2009

Revocaciones. Apoderado: ORCHARD SIMON THOMAS;CERNUDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;LLOVET BARQUERO JOSE MANUEL;MEJIA ROJO JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: ORCHARD SIMON THOMAS;CERNUDA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;LLOVET BARQUERO JO...