Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 14 tarjetas
04/12/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-485226

Revocaciones — 04/12/2018

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER. Apo.Man.Soli: REYES RAMIREZ LEONARDO. Cambio de denominación social. LYNTIA NETWORKS SA. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA, 259D (TORRE ESPACIO)...

14/08/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-337583

Nombramientos — 14/08/2018

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA NIETO NUBIOLA PABLO;CABEZUELA GONZALEZ OSCAR;GARRALDA CABANAS LUCIA;DE LEYVA MERIDA AMPARO;SEGURA DE LA MONJA IGNACIO. Datos registrales. T 36971 , F 136, S 8, H M 508573, I/A 52 ( 7.08.1...

14/08/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-337584

Revocaciones — 14/08/2018

Revocaciones. Apoderado: GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO;FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO;RAMA PENAS JORGE;QUEMADA SAENZ DE BADILLOS JORGE;RAILHAC THOMAS;GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO;FRAGA DIAZ-CHIRON JUAN FRANCISCO;LACA...

07/08/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-327650

Ceses/dimisiones — 07/08/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: QUEMADA SAENZ DE BADILLOS JORGE;TAZON GARCIA JOSE ANTONIO. Presidente: TAZON GARCIA JOSE ANTONIO. Consejero: GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO;SEGURA MARTIN MIGUEL JUAN. SecreNoConsj: CAJIGAS GA...

06/08/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-325765

Ceses/dimisiones — 06/08/2018

Ceses/Dimisiones. Consejero: RAILHAC THOMAS. Nombramientos. Consejero: SEGURA MARTIN MIGUEL JUAN. Datos registrales. T 36971 , F 131, S 8, H M 508573, I/A 49 (30.07.18).

03/04/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-148227

Revocaciones — 03/04/2018

Revocaciones. Apoderado: JUAN FERRER ROSA. Datos registrales. T 28235 , F 98, S 8, H M 508573, I/A 46 (22.03.18).

12/01/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-17499

Revocaciones — 12/01/2018

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER;GARCIA VILAS JOSE BENITO;GARCIA COBALEDA MANUEL;GOMEZ FERRER BALTASAR;FELIP FONT JOAN;MENENDEZ FERNANDEZ JAUME;BASTIDA FENOY JOSE;QUESADA MORALES VICTOR ANTONIO;Q...

13/12/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-486693

Nombramientos — 13/12/2017

Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO;REYES RAMIREZ LEONARDO;RIVERA PEREZ ANGEL. Datos registrales. T 28235 , F 95, S 8, H M 508573, I/A 44 ( 4.12.17).

07/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-236930

Nombramientos — 07/06/2017

Nombramientos. Apoderado: GARCIA DEL CERRO PRIETO IÑIGO;LACASA FUERTES FRANCISCO JAVIER;PEREZ-BEDMAR DELGADO PABLO;REYES RAMIREZ LEONARDO;RIVERA PEREZ ANGEL;LOPEZ MUÑOZ PILAR;APARICIO MUÑOZ MARIA. Datos registrales. T 2...

20/01/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-22258

Reelecciones — 20/01/2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28235 , F 91, S 8, H M 508573, I/A 38 (11.01.16).

23/04/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-169142

Nombramientos — 23/04/2015

Nombramientos. Apoderado: GARRIDO RODRIGUEZ DANIEL. Datos registrales. T 28235 , F 89, S 8, H M 508573, I/A 36 (15.04.15).

23/12/2014 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-523478

Modificaciones estatutarias — 23/12/2014

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12. Otros conceptos: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE FECHA DEL CIERRE DEL EJERCICIO SE MODIFICA EL ARTICULO 35 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales....

04/12/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-496706

Ceses/dimisiones — 04/12/2014

Ceses/Dimisiones. Presidente: QUEMADA SAENZ-BADILLO JORGE. Nombramientos. Consejero: TAZON GARCIA JOSE ANTONIO. Presidente: TAZON GARCIA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28235 , F 88, S 8, H M 508573, I/A 33 (27.11.14...

13/11/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-459770

Reelecciones — 13/11/2014

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28235 , F 87, S 8, H M 508573, I/A 32 ( 5.11.14).