Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2012 24 tarjetas
12/11/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-462531

Nombramientos — 12/11/2012

Nombramientos. Apo.Sol.: CAJA AGUERO ALBERTO;ARANDA DE LA TORRE JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 1561 , F 104, S 8, H Z 11406, I/A 204 (30.10.12).

12/11/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-462532

Revocaciones — 12/11/2012

Revocaciones. Apoderado: QUIROGA GAYLLOSO FRANCISCO JAVIER;STENGER GIRALT CARLOS. Apo.Sol.: GALLEGO CUSTODIO JUAN MANUEL;FERNANDEZ MARTINEZ JUAN JOSE;IRIARTE RODRIGUEZ KEPAApoderado: LAMELA JUIZ GONZALO. Apo.Sol.: SAN E...

12/11/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-462533

Revocaciones — 12/11/2012

Revocaciones. Apoderado: SAINZ VIÑAU JOSE ANGEL;DOBLAS CAMPOS JUAN ANTONIO;MORENO FRAILE ALBERTO;MACHO RONCO GUILLERMO;ROGER GOMEZ JOAQUIN BENITO. Apo.Sol.: MUÑOZ MUÑOZ DAVID;GARCIA LOPEZ GUSTAVO;ORTIGOSA YOLDI ARMANDO....

12/11/2012 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-462534

Nombramientos — 12/11/2012

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ PUENTE FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 1561 , F 105, S 8, H Z 11406, I/A 207 (30.10.12).

17/07/2012 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-301632

Reelecciones — 17/07/2012

Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Aud.C.Con.: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1561 , F 103, S 8, H Z 11406, I/A 203 ( 4.07.12).

30/01/2012 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-46079

Ampliación de capital — 30/01/2012

Ampliación de capital. Suscrito: 4.882.133,35 Euros. Desembolsado: 4.882.133,35 Euros. Resultante Suscrito: 50.109.366,65 Euros. Resultante Desembolsado: 50.109.366,65 Euros. Datos registrales. T 1561 , F 103, S 8, H Z...

30/01/2012 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-46080

Revocaciones — 30/01/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: VIDAL RIOS JOSE;BUSTILLO GONZALEZ HILARIO;MARTINEZ MESA DAVID. Datos registrales. T 1561 , F 103, S 8, H Z 11406, I/A 202 (18.01.12).

04/11/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-439009

Nombramientos — 04/11/2011

Nombramientos. Apoderado: ACEVES LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 1561 , F 103, S 8, H Z 11406, I/A 200 (21.10.11).

05/10/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-397473

Nombramientos — 05/10/2011

Nombramientos. Apoderado: HERRERO GALLARDO CRISTINA. Datos registrales. T 1561 , F 102, S 8, H Z 11406, I/A 198 (22.09.11).

05/10/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-397474

Revocaciones — 05/10/2011

Revocaciones. Apoderado: DOPICO VARELA DIEGO;HERRERO BADENAS ELIAS. Apo.Sol.: JIMENEZ OCON ARTURO FERNANDO;PITA-ROMERO CAAMAÑO JUAN;VELASCO MENA JOSE LUIS. Apoderado: SARASA DOMINGO ALVARO. Apo.Sol.: SARASA DOMINGO ALVA...

22/06/2011 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-267514

Reelecciones — 22/06/2011

Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1561 , F 102, S 8, H Z 11406, I/A 196 ( 8.06.11).

22/06/2011 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-267515

Reelecciones — 22/06/2011

Reelecciones. Aud.C.Con.: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1561 , F 102, S 8, H Z 11406, I/A 197 ( 8.06.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 119 Miércoles 22 de junio de 2011 Pág. 31879 c...

03/02/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-48543

Nombramientos — 03/02/2011

Nombramientos. Apoderado: GARCIA BIEL VICTOR. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 194 (24.01.11).

03/02/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-48544

Nombramientos — 03/02/2011

Nombramientos. Apoderado: SANTOS NAVAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1561 , F 102, S 8, H Z 11406, I/A 195 (24.01.11).

10/01/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-8944

Nombramientos — 10/01/2011

Nombramientos. Apo.Sol.: PITA-ROMERO CAAMAÑO JUAN;ORTIGOSA YOLDI ARMANDO;LOPEZ AVILA LUIS. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 192 (29.12.10).

10/01/2011 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-8945

Revocaciones — 10/01/2011

Revocaciones. Apoderado: CAMPILLO TRIAS FRANCESC;GUTIERREZ CORRES RODOLFO;ALBADALEJO CHEVILLARD MANUEL. Apo.Sol.: NAVARRO CAPDEVILA MERCEDES. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 193 (29.12.10).

12/08/2010 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-318308

Revocaciones — 12/08/2010

Revocaciones. Apoderado: RIO SANCHEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 191 ( 3.08.10).

30/07/2010 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-301511

Reelecciones — 30/07/2010

Reelecciones. Aud.C.Con.: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 189 (21.07.10).

30/07/2010 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-301512

Reelecciones — 30/07/2010

Reelecciones. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1561 , F 101, S 8, H Z 11406, I/A 190 (21.07.10).

02/06/2010 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-221163

Nombramientos — 02/06/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO CAPDEVILA MERCEDES;RAMOS SANTOS SANTIAGO. Datos registrales. T 1561 , F 100, S 8, H Z 11406, I/A 188 (24.05.10).

04/03/2010 Sec. I Modificaciones estatutarias Zaragoza
Zaragoza-93709

Modificaciones estatutarias — 04/03/2010

Modificaciones estatutarias. "Artículo 27.2. Retribución de los Administradores. El cargo de administrador es retribuido. La remuneración consistiráen una cantidad fija que deberá ser determinada anualmente por la Junta...

04/03/2010 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-93710

Revocaciones — 04/03/2010

Revocaciones. Apoderado: EIZAGUIRRE ORBE FERNANDO;FERRER PEREZ RAMON. Datos registrales. T 1561 , F 100, S 8, H Z 11406, I/A 187 (23.02.10).

29/01/2010 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-39667

Revocaciones — 29/01/2010

Revocaciones. Apo.Sol.: MAZO SANAGUSTIN RAFAEL. Datos registrales. T 1561 , F 100, S 8, H Z 11406, I/A 185 (20.01.10).

28/04/2009 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-200234

Revocaciones — 28/04/2009

Revocaciones. Apoderado: JIMENEZ LARA ANGEL. Datos registrales. T 1561 , F 99, S 8, H Z 11406, I/A 179 (17.04.09).