Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 12 tarjetas
31/10/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-436266

Disolución — 31/10/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 37022 , F 31, S 8, H M 48416, I/A 78 (23.10.18).

29/05/2018 Sec. I Otros conceptos: ANEXO AL PROYECTO DE FUSION DE MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA COMO ABSORBENTE Y SCANWELL LOGISTICS SPAIN SL , SCANWELL LOGISTICS PAMPLONA SA Y TRACOESA TRANSPORT SA, COMO ABSORBIDAS Madrid
Madrid-226008

Otros conceptos: anexo al proyecto de fusion de manipulaciones portuarias grupajes y transitos sa como absorbente y scanwell logistics spain sl , scanwell logistics pamplona sa y tracoesa transport sa, como absorbidas — 29/05/2018

Otros conceptos: ANEXO AL PROYECTO DE FUSION DE MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA COMO ABSORBENTE Y SCANWELL LOGISTICS SPAIN SL , SCANWELL LOGISTICS PAMPLONA SA Y TRACOESA TRANSPORT SA, COMO ABSORBIDAS....

24/05/2018 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-220286

Sociedad unipersonal — 24/05/2018

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA. Datos registrales. T 37022 , F 30, S 8, H M 48416, I/A 77 (14.05.18).

04/04/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-150097

Revocaciones — 04/04/2018

Revocaciones. Apoderado: DELGADO PARRA FRANCISCO;CABEZA RIVAS FRANCISCO;DELGADO PARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 37022 , F 30, S 8, H M 48416, I/A 76 (23.03.18).

23/02/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-89484

Nombramientos — 23/02/2017

Nombramientos. Apoderado: BOU GIL JOSE ANTONIO;DELGADO PARRA FRANCISCO. Datos registrales. T 30209 , F 168, S 8, H M 48416, I/A 73 (15.02.17).

09/02/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-57352

Nombramientos — 09/02/2016

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ MUÑOZ MARIA. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 70 (29.01.16).

29/12/2015 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-527691

Reelecciones — 29/12/2015

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30209 , F 167, S 8, H M 48416, I/A 69 (18.12.15).

24/04/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-178673

Nombramientos — 24/04/2014

Nombramientos. Apoderado: BOU GIL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30209 , F 165, S 8, H M 48416, I/A 63 (15.04.14).

23/12/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-547016

Nombramientos — 23/12/2013

Nombramientos. Apoderado: CIA GARCIA DOMINGO. Datos registrales. T 30209 , F 163, S 8, H M 48416, I/A 61 (16.12.13). 547017 - FOMENTO PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE TRES SA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE R...

09/01/2013 Sec. I Fusión por absorción Madrid
Madrid-9048

Fusión por absorción — 09/01/2013

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: TRACOESA BARCELONA SL. Datos registrales. T 17995 , F 224, S 8, H M 48416, I/A 54 (28.12.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 5 Miércoles 9 de enero de 2013 Pág....

24/08/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-354032

Revocaciones — 24/08/2012

Revocaciones. Apoderado: ESPINOSA ADAMEZ VICENTE;MORENO BRIBIAN IGNACIO;PUEBLA ARRIBAS GABRIEL;ESTACIO JIMENEZ MIGUEL;MORENO LOPEZ PABLO. Apo.Sol.: CERVERA GARNICA RAMIRO. Apo.Man.Soli: MORENO BRIBIAN IGNACIO RAMON. Dat...

10/11/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-446328

Nombramientos — 10/11/2011

Nombramientos. Apoderado: MORENO LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 17995 , F 221, S 8, H M 48416, I/A 46 (27.10.11).