Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
19/12/2016 Sec. I Otros conceptos: COMUNICACION A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 233 Madrid
Madrid-511444

Otros conceptos: comunicacion a los efectos del articulo 233 — 19/12/2016

Otros conceptos: COMUNICACION A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 233.2 RRM, DE LA CAMARA DE COMERCIO DE PISA, COMUNICANDO LA FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA -ABSORBIDA-, QUE QUEDA DISUELTA Y EXTINGUIDA. Extinci...

09/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-368753

Nombramientos — 09/09/2015

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33796 , F 218, S 8, H M 388990, I/A 15 (31.08.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 172 Miércoles 9 de septiembre de 2015 Pág. 39781 cve: BORME-...

09/09/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-368754

Nombramientos — 09/09/2015

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 33796 , F 218, S 8, H M 388990, I/A 16 (31.08.15).

08/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-366923

Ceses/dimisiones — 08/09/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: OELERT JOCHEN. Nombramientos. Consejero: DELOBELLE INGE LIEVE VEERLE. Datos registrales. T 21830 , F 136, S 8, H M 388990, I/A 14 (31.08.15).

04/11/2014 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Madrid
Madrid-444412

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 04/11/2014

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: CARNEIRO MAURO AUGUSTO. Presidente: CARNEIRO MAURO AUGUSTO. Cons.Del.Sol: CARNEIRO MAURO AUGUSTO. Datos registrales. T 21830 , F 133, S 8, H M 388990, I/A M (27.10.14...