Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 24 tarjetas
24/10/2019 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-441672

Nombramientos — 24/10/2019

Nombramientos. Auditor: PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL. Datos registrales. T 2528 , F 21, S 8, H SS 3748, I/A 63 (17.10.19).

21/12/2018 Sec. I Ampliacion del objeto social Gipuzkoa
Gipuzkoa-512359

Ampliacion del objeto social — 21/12/2018

Ampliacion del objeto social. ª La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, terrenos, conjuntos residenciales, urbanizaciones opromociones...

31/10/2018 Sec. I Reelecciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-435827

Reelecciones — 31/10/2018

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2528 , F 20, S 8, H SS 3748, I/A 61 (25.10.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 210 Miércoles 31 de octubre de 2018 Pág. 46828...

29/08/2018 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-354814

Revocaciones — 29/08/2018

Revocaciones. Apoderado: CABAÑES DE BLAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2528 , F 20, S 8, H SS 3748, I/A 60 (21.08.18).

14/02/2018 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-72295

Revocaciones — 14/02/2018

Revocaciones. Apoderado: HEVIA GONZALEZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ ECHEZARRAGA JOSE-MARIA. Datos registrales. T 2528 , F 19, S 8, H SS 3748, I/A 59 ( 1.02.18).

05/04/2017 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-152715

Nombramientos — 05/04/2017

Nombramientos. Apoderado: SANTAMARIA YELA MIGUEL. Datos registrales. T 2528 , F 18, S 8, H SS 3748, I/A 58 (22.03.17).

02/03/2017 Sec. I Reducción de capital Gipuzkoa
Gipuzkoa-100621

Reducción de capital — 02/03/2017

Reducción de capital. Importe reducción: 269.205,00 Euros. Resultante Suscrito: 94.975,00 Euros. Datos registrales. T 2528 , F 18, S 8, H SS 3748, I/A 57 (21.02.17).

29/12/2016 Sec. I Fusión por absorción Gipuzkoa
Gipuzkoa-528445

Fusión por absorción — 29/12/2016

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: REHABILITACIONES GENERALES DE VIVIENDAS SA. Datos registrales. T 2528 , F 17, S 8, H SS 3748, I/A 56 (14.12.16).

22/06/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-262701

Ceses/dimisiones — 22/06/2016

Ceses/Dimisiones. Auditor: BSK BASK CONSULTING SL. Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2528 , F 16, S 8, H SS 3748, I/A 55 (13.06.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL...

04/01/2016 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-772

Revocaciones — 04/01/2016

Revocaciones. Apoderado: VICENTE ALVARO MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 2528 , F 16, S 8, H SS 3748, I/A 54 (17.12.15).

22/07/2015 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-302896

Revocaciones — 22/07/2015

Revocaciones. Apoderado: NAZABAL ZUBIZARRETA MARIA MERCEDES;ORBEGOZO LARRION ARKAITZ. Nombramientos. Apoderado: CABAÑES DE BLAS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2528 , F 16, S 8, H SS 3748, I/A 53 (10.07.15).

06/04/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Gipuzkoa
Gipuzkoa-141490

Cambio de domicilio social — 06/04/2015

Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO VALVERDE NUMERO 2 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN). Datos registrales. T 2528 , F 14, S 8, H SS 3748, I/A 51 (24.03.15).

31/12/2014 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-534348

Nombramientos — 31/12/2014

Nombramientos. Apoderado: VICENTE ALVARO MANUEL ANTONIO. Datos registrales. T 2528 , F 13, S 8, H SS 3748, I/A 50 (16.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 249 Miércoles 31 de diciembre de 2014 Pág. 57735...

19/12/2014 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-518400

Revocaciones — 19/12/2014

Revocaciones. Apoderado: GARIN ELUSTONDO IMANOL. Datos registrales. T 2528 , F 13, S 8, H SS 3748, I/A 49 (12.12.14).

05/11/2014 Sec. I Reelecciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-445598

Reelecciones — 05/11/2014

Reelecciones. Auditor: BSK BASK CONSULTING SL. Datos registrales. T 2528 , F 12, S 8, H SS 3748, I/A 46 (28.10.14).

27/05/2013 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-241807

Revocaciones — 27/05/2013

Revocaciones. Apoderado: ORBEGOZO LARRION ARKAITZ. Nombramientos. Apoderado: ORBEGOZO LARRION ARKAITZ. Datos registrales. T 2528 , F 12, S 8, H SS 3748, I/A 45 (16.05.13).

13/09/2012 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-375627

Nombramientos — 13/09/2012

Nombramientos. Apoderado: GARIN ELUSTONDO IMANOL. Datos registrales. T 2528 , F 11, S 8, H SS 3748, I/A 42 ( 4.09.12).

13/09/2012 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-375628

Nombramientos — 13/09/2012

Nombramientos. Apoderado: ORBEGOZO LARRION ARKAITZ. Datos registrales. T 2528 , F 11, S 8, H SS 3748, I/A 43 ( 4.09.12).

13/09/2012 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-375629

Nombramientos — 13/09/2012

Nombramientos. Apoderado: NAZABAL ZUBIZARRETA MARIA MERCEDES. Datos registrales. T 2528 , F 12, S 8, H SS 3748, I/A 44 ( 4.09.12).

12/09/2012 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-373811

Revocaciones — 12/09/2012

Revocaciones. Apoderado: GARIN IRADI SIMON-ESTEBAN. Apo.Sol.: NUIN GORRI JOSE-LUIS. Apoderado: GARIN ELUSTONDO MIKEL. Apo.Sol.: GARIN ELUSTONDO IMANOL. Datos registrales. T 2528 , F 11, S 8, H SS 3748, I/A 41 ( 3.09.12)...

12/01/2012 Sec. I Reelecciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-14779

Reelecciones — 12/01/2012

Reelecciones. Auditor: BSK BASK CONSULTING SL. Datos registrales. T 2528 , F 11, S 8, H SS 3748, I/A 40 (30.12.11).

16/09/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Gipuzkoa
Gipuzkoa-373585

Ceses/dimisiones — 16/09/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARIN IRADI SIMON-ESTEBAN. Presidente: GARIN IRADI SIMON-ESTEBAN. Consejero: GARCIA PRADO FERNANDO;LLOPIS ARAMENDI ENRIQUE-ANGEL;ILLARRAMENDI ECENARRO NICOLAS. Secretario: NUIN GORRI JOSE-LU...

16/09/2011 Sec. I Revocaciones Gipuzkoa
Gipuzkoa-373586

Revocaciones — 16/09/2011

Revocaciones. Apoderado: HEVIA GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 1183 , F 154, S 8, H SS 3748, I/A 38 ( 6.09.11).

16/09/2011 Sec. I Nombramientos Gipuzkoa
Gipuzkoa-373587

Nombramientos — 16/09/2011

Nombramientos. Apoderado: HEVIA GONZALEZ CARLOS. Datos registrales. T 1183 , F 154, S 8, H SS 3748, I/A 39 ( 6.09.11).