Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 11 tarjetas
07/02/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-56724

Ceses/dimisiones — 07/02/2019

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BASTARRECHE SAGUES IÑIGO. Consejero: CABEZON PINILLA IGNACIO;SOLIS O'SHEA LUIS;BARBARA KOPEC MARTA. Presidente: SOLIS O'SHEA LUIS. Nombramientos. Liquidador: SOLIS O'SHEA LUIS. Disolución...

26/12/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-505023

Revocaciones — 26/12/2017

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SOLIS O'SHEA LUIS;CABEZON PINILLA IGNACIO;DIAZ VALDENEBRO BEATRIZ;DURAN CASARES NIEVES. Nombramientos. Apo.Manc.: SOLIS O'SHEA LUIS;DURAN CASARES NIEVES;DIAZ VALDENEBRO BEATRIZ;MASDEVALL TORM...

03/04/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-148540

Ceses/dimisiones — 03/04/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: ESTEVE ARCOS RAFAEL. Presidente: ESTEVE ARCOS RAFAEL. Nombramientos. Consejero: BARBARA KOPEC MARTA. Presidente: SOLIS O'SHEA LUIS. Datos registrales. T 31850 , F 213, S 8, H M 573179, I/A 8...

19/06/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-250276

Ceses/dimisiones — 19/06/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCILASO DE LA VEGA OCAÑA FERNANDO. Presidente: GARCILASO DE LA VEGA OCAÑA FERNANDO. Con.Delegado: GARCILASO DE LA VEGA OCAÑA FERNANDO. Consejero: GARY PAUL IAN. Revocaciones. BOLETÍN OFICI...

19/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-250277

Nombramientos — 19/06/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: ESTEVE ARCOS RAFAEL;SOLIS O`SHEA LUIS;CHEDAILLE PIERRE RAYMOND;DIAZ VALDENEBRO BEATRIZ;PESQUERA PRADOS PEDRO LUIS;DURAN CASARES NIEVES. Datos registrales. T 31850 , F 210, S 8, H M 573179, I/A...

19/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-250278

Nombramientos — 19/06/2015

Nombramientos. Apoderado: BARROSO GONZALEZ OLGA MARIA. Datos registrales. T 31850 , F 212, S 8, H M 573179, I/A 5 (11.06.15).

19/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-250279

Nombramientos — 19/06/2015

Nombramientos. Apoderado: DE MIGUEL UMBRIA MARIA DE LOS ANGELES. Datos registrales. T 31850 , F 213, S 8, H M 573179, I/A 6 (11.06.15).

17/07/2012 Sec. I Revocaciones Sevilla
Sevilla-301282

Revocaciones — 17/07/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TALLADA MESTRE JAVIER;FERNANDEZ PEREZ SEVERO. Datos registrales. T 4467 , F 102, S 8, H SE 28112, I/A 30 ( 4.07.12).

08/02/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Sevilla
Sevilla-56086

Ceses/dimisiones — 08/02/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: COSTA MASSIMO. Nombramientos. Consejero: PRIETO JAIME E. Datos registrales. T 4467 , F 101, S 8, H SE 28112, I/A 28 (27.01.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 26 Martes 8 de feb...

28/12/2010 Sec. I Modificaciones estatutarias Sevilla
Sevilla-482279

Modificaciones estatutarias — 28/12/2010

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. AVDA DE LA CONSTITUCION 7 (SEVILLA). Datos registrales. T 4467 , F 101, S 8, H SE 28112, I/A 27 (14.12.10).

03/03/2009 Sec. I Nombramientos Sevilla
Sevilla-110724

Nombramientos — 03/03/2009

Nombramientos. Apoderado: BARROSO GONZALEZ OLGA MARIA. Datos registrales. T 4467 , F 99, S 8, H SE 28112, I/A 24 (18.02.09).