Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 20 tarjetas
26/05/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-223784

Ceses/dimisiones — 26/05/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: GARRIDO-LESTACHE BURDIEL JUAN LUIS;GUIJARRO URUEÑA OLGA;MARCELA GAGNA MIRIAM. Secretario: SANCHEZ-MORENO GOMEZ JAVIER. Presidente: MARCELA GAGNA MIRIAM. Consejero: BARROSO OLAZABAL EUGENIO....

26/05/2016 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-223785

Nombramientos — 26/05/2016

Nombramientos. Presidente: BJORN ANDERSEN JENS. Secretario: HESSELBERG LUND JENS. Apo.Man.Soli: MAS ACOSTA IBAN;RODRIGUEZ GOMEZ MARIA DE LAS NIEVES. Apo.Sol.: BELAUSTEGUIGOITIA MATEACHE ENEKO;PEÑA RAMILO ANGEL. Datos re...

09/04/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-148197

Ceses/dimisiones — 09/04/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: JAN VAN AALST DANIEL. Presidente: JAN VAN AALST DANIEL. Nombramientos. Presidente: MARCELA GAGNA MIRIAM. Consejero: BARROSO OLAZABAL EUGENIO. Datos registrales. T 3439 , F 44, S 8, H C 38897...

09/04/2015 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-148198

Revocaciones — 09/04/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ GOMEZ NIEVES. Datos registrales. T 3439 , F 45, S 8, H C 38897, I/A 28 (25.03.15).

11/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-105490

Ceses/dimisiones — 11/03/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: JOSPH POUBLON ALAIN GUY. Presidente: JOSPH POUBLON ALAIN GUY. Nombramientos. Consejero: JAN VAN AALST DANIEL. Presidente: JAN VAN AALST DANIEL. Modificaciones estatutarias. Artículo de los e...

07/01/2015 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-2277

Revocaciones — 07/01/2015

Revocaciones. Apo.Sol.: ORDUNA VELA FERNANDO;NIETO POL MARIA TERESA;NOGUEIRA CHAVER FEDERICO;RODRIGUEZ ESPIÑEIRA HORACIO FERNANDO;OUJO IZCUE RAIMUNDO MANUEL. Datos registrales. T 3439 , F 44, S 8, H C 38897, I/A 24 (29....

04/08/2014 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-319136

Revocaciones — 04/08/2014

Revocaciones. Apo.Manc.: CHAVER REY ANTONIO. Datos registrales. T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 23 (28.07.14).

18/02/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-75535

Ceses/dimisiones — 18/02/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: FREESE JOCHEN. Datos registrales. T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 22 (11.02.14).

19/11/2013 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-492522

Nombramientos — 19/11/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: SORIANO SANCHEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 19 (13.11.13).

19/11/2013 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-492523

Revocaciones — 19/11/2013

Revocaciones. Apo.Manc.: MURIEL PANDORI CYNTHIA. Datos registrales. T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 20 (13.11.13).

07/11/2013 Sec. I Sociedad unipersonal A Coruña
A Coruña-474783

Sociedad unipersonal — 07/11/2013

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: UTI IBERIA SL. Datos registrales. T 3439 , F 43, S 8, H C 38897, I/A 18 (30.10.13).

19/02/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-82198

Ceses/dimisiones — 19/02/2013

Ceses/Dimisiones. Presidente: ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero: JOSPH POUBLON ALAIN GUY. Presidente: JOSPH POUBLON ALAIN GUY. Datos registrales. T 3439 , F 41, S 8, H C 38897, I/A 14 (11.02.13).

14/11/2012 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-465333

Revocaciones — 14/11/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUIJARRO URUEÑA OLGA. Datos registrales. T 3439 , F 41, S 8, H C 38897, I/A 12 ( 2.11.12).

18/10/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-423627

Ceses/dimisiones — 18/10/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Presidente: ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Cons.Del.Sol: ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Consejero: KUMMETZ ERIC. Secretario: KUMMETZ ERIC. Consejero: CHAVER REY ANTONIO...

06/02/2012 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-58319

Nombramientos — 06/02/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MIGUEZ VILLAVERDE MIGUEL;ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA. Datos registrales. T 3439 , F 40, S 8, H C 38897, I/A 10 (25.01.12).

03/02/2012 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-54633

Nombramientos — 03/02/2012

Nombramientos. Apo.Man.Soli: REVIRIEGO GONZALEZ FERNANDO;GUIJARRO URUEÑA OLGA. Datos registrales. T 3101 , F 19, S 8, H C 38897, I/A 8 (25.01.12).

03/02/2012 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-54634

Revocaciones — 03/02/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: ESCARIO PASCUAL CARLOS LUIS;ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA;KUMMETZ ERIC;CHAVER REY ANTONIO;FONT HERNANDEZ CARLOS. Apo.Manc.: SANTOS MARTIN JUAN MANUEL;RODRIGUEZ GOMEZ NIEVES;COBERTERA RAMOS JOSE...

19/02/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-72103

Ceses/dimisiones — 19/02/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: CHAVER REY ANTONIO. Presidente: CHAVER REY ANTONIO. Consejero: BORRAJO CASTANEDO ENRIQUE;AFONSO-MORAES REY ANTONIO;ORDUNA VELA FERNANDO. Secretario: ORDUNA VELA FERNANDO. Con.Delegado: CHAVE...

19/02/2010 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-72104

Nombramientos — 19/02/2010

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ESCARIO PASCUAL CARLOS LUIS;ESCARIO PASCUAL JOSE MARIA;KUMMETZ ERIC;CHAVER REY ANTONIO;FONT HERNANDEZ CARLOS. Apo.Manc.: SANTOS MARTIN JUAN MANUEL;RODRIGUEZ GOMEZ NIEVES;COBERTERA RAMOS JOSE...

19/02/2010 Sec. I Declaración de unipersonalidad A Coruña
A Coruña-72105

Declaración de unipersonalidad — 19/02/2010

Declaración de unipersonalidad. Socio único: GRUPO SLI & UNION SL. Otros conceptos: Adquiere el carácter de UNIPERSONAL.- Datos registrales. T 3101 , F 19, S 8, H C 38897, I/A 7 ( 9.02.10).