Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 6 tarjetas
25/05/2018 Sec. I Disolución Madrid
Madrid-222114

Disolución — 25/05/2018

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 35299 , F 161, S 8, H M 634577, I/A 6 (18.05.18).

22/11/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-458531

Nombramientos — 22/11/2017

Nombramientos. Apoderado: AEDAS HOMES SA. Datos registrales. T 35299 , F 60, S 8, H M 634577, I/A 5 (14.11.17).

18/05/2017 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-205778

Sociedad unipersonal — 18/05/2017

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: SPV REOCO 1 SL. Datos registrales. T 35299 , F 56, S 8, H M 634577, I/A 2 ( 9.05.17).

18/05/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-205779

Nombramientos — 18/05/2017

Nombramientos. Apoderado: AEDAS HOMES SL. Datos registrales. T 35299 , F 57, S 8, H M 634577, I/A 3 ( 9.05.17).

18/05/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-205780

Ceses/dimisiones — 18/05/2017

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: AZCONA SAN JULIAN JAIME JOSE;ALVAREZ LLORCA MERCEDES. Nombramientos. Consejero: OÑATE RINO MIGUEL;MARTINEZ MONTERO DAVID;DELGADO MONTERO ALBERTO. Presidente: OÑATE RINO MIGUEL. Secretario:...

29/11/2016 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-482720

Constitución — 29/11/2016

Constitución. Comienzo de operaciones: 8.11.16. Objeto social: ADQUISICION, PROMOCION Y REHABILITACION DE CUALESQUIERA INMUEBLES. Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 143 11º - DERECHA (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. De...