Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 5 tarjetas
21/01/2015 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-23724

Modificaciones estatutarias — 21/01/2015

Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3. Cambio de domicilio social. AVDA DE AMERICA 115 (MADRID). Datos registrales. T 19505 , F 209, S 8, H M 311018, I/A 24 (14.01.15).

04/12/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-496687

Revocaciones — 04/12/2014

Revocaciones. Apo.Man.Soli: SAGASTA REUSSI CARLOS IGNACIO. Apoderado: DA COSTA COIMBRA ANTONIO MANUEL;PORTELA DE PABLO ROSALIA. Datos registrales. T 19505 , F 209, S 8, H M 311018, I/A 23 (27.11.14).

08/07/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-280824

Nombramientos — 08/07/2014

Nombramientos. Apoderado: DA COSTA COIMBRA ANTONIO MANUEL;PORTELA DE PABLO ROSALIA. Datos registrales. T 19505 , F 206, S 8, H M 311018, I/A 19 (30.06.14).

10/04/2014 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-160823

Revocaciones — 10/04/2014

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MERCADER HERRERO GUILLERMO. Datos registrales. T 19505 , F 206, S 8, H M 311018, I/A 18 ( 3.04.14).

22/02/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-90626

Revocaciones — 22/02/2013

Revocaciones. Apoderado: FOLGADO DELGADO DAVID. Datos registrales. T 19505 , F 205, S 8, H M 311018, I/A 15 (14.02.13).