Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 11 tarjetas
07/12/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-480171

Ceses/dimisiones — 07/12/2017

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: TINKLER ZAMPIGA VANESSA LUISE;WANEK DANIEL LOUIS;ADROHER PEREZ ESTHER. Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 28690 , F 85, S 8, H M 471229, I/A 24 (28.11.17).

18/01/2017 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-26253

Modificaciones estatutarias — 18/01/2017

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 4. Duración, fecha de comienzo de sus operaciones y cierre de los ejercicios sociales.-. Datos registrales. T 28690 , F 85, S 8, H M 471229, I/A 22 (11.01...

29/09/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-393382

Ceses/dimisiones — 29/09/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: TILSTONE DAVID PAUL;VELASCO REYES VICTORIANO. Presidente: TILSTONE DAVID PAUL. Secretario: VELASCO REYES VICTORIANO. Consejero: CAÑO STERCK JUAN. Nombramientos. Adm. Solid.: TINKLER ZAMPIGA...

29/09/2016 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-393383

Revocaciones — 29/09/2016

Revocaciones. Apo.Sol.: TILSTONE DAVID PAUL;VAZQUEZ GUILLEN FERNANDEZ DE LA RIVA ANTONIO;CARNERO PRIETO JESUS DANIEL;CRUZ TORRES RAFAEL;TILSTONE DAVID PAUL. Apoderado: AUREN FINANZAS CORPORATIVAS INTL SL;VELASCO REYES V...

26/04/2016 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-180609

Reelecciones — 26/04/2016

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28690 , F 83, S 8, H M 471229, I/A 19 (15.04.16).

28/04/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-182064

Reelecciones — 28/04/2014

Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28690 , F 83, S 8, H M 471229, I/A 17 (16.04.14).

03/04/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-152987

Ceses/dimisiones — 03/04/2012

Ceses/Dimisiones. Consejero: KRAGT DANNY HENRY. Presidente: KRAGT DANNY HENRY. Secretario: GARRIGUES CALDERON BELEN. VsecrNoConsj: SMEETS MARC. Consejero: GILBERT BENOIT ANDRE JOSEPH. Nombramientos. Consejero: VELASCO R...

03/04/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-152988

Revocaciones — 03/04/2012

Revocaciones. Apo.Sol.: KRAGT DANNY HENRY. Apo.Manc.: TILSTONE DAVID PAUL;KRAGT DANNY HENRY. Nombramientos. Apo.Sol.: TILSTONE DAVID PAUL. Datos registrales. T 28690 , F 82, S 8, H M 471229, I/A 15 (22.03.12).

03/04/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-152989

Revocaciones — 03/04/2012

Revocaciones. Apoderado: GILBERT BENOIT ANDRE JOSEPH;KRAGT DANNY HENRY;TILSTONE DAVID PAUL;GILBERT BENOIT ANDRE JOSEPH. Nombramientos. Apo.Sol.: TILSTONE DAVID PAUL. Apo.Manc.: VELASCO REYES VICTORIANO. Apo.Sol.: CAÑO S...

26/05/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-225622

Nombramientos — 26/05/2011

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 26145 , F 64, S 8, H M 471229, I/A 11 (16.05.11).

02/04/2009 Sec. I Sociedad unipersonal Madrid
Madrid-162711

Sociedad unipersonal — 02/04/2009

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DESARROLLOS EMPRESARIALES TRAFALGAR SL. Datos registrales. T 26145 , F 60, S 8, H M 471229, I/A 8 (23.03.09).