Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2026 19 tarjetas
29/01/2026 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Pontevedra
Pontevedra-48797

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 29/01/2026

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;BARREIRO RODRIGUEZ ROBERTO. Datos registrales. S 8 ,...

05/06/2019 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Pontevedra
Pontevedra-240543

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 05/06/2019

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 373...

17/01/2017 Sec. I Fusión por absorción Pontevedra
Pontevedra-23826

Fusión por absorción — 17/01/2017

Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: RESGAL VIGO SL. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 122, S 8, H PO 51791, I/A 7 (10.01.17).

28/11/2016 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-481270

Revocaciones — 28/11/2016

Revocaciones. Apoderado: AGUILAR LOPEZ MANUEL. Apo.Sol.: SANCHEZ GORDON ROMAN;GUTIERREZ AMOROS MARIA DEL ROSARIO;ALVAREZ ACEVEDO ALFONSO. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 121, S 8, H PO 51791, I/A 6 (18.11.16).

24/04/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Pontevedra
Pontevedra-171352

Cambio de domicilio social — 24/04/2015

Cambio de domicilio social. C/ POLICARPO SANZ 24-26 (VIGO). Datos registrales. T 3732, L 3732, F 121, S 8, H PO 51791, I/A 5 (16.04.15).

09/05/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-199115

Ceses/dimisiones — 09/05/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CASTRO SEOANE MARIA DIGNA. Nombramientos. Adm. Mancom.: VILANOVA DACOSTA JOSE LUIS;CASTRO DOMINGUEZ JUAN JOSE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administrado...

14/09/2011 Sec. I Cambio de domicilio social Pontevedra
Pontevedra-371296

Cambio de domicilio social — 14/09/2011

Cambio de domicilio social. AVDA GARCIA BARBON 1-3 (VIGO). Datos registrales. T 3732, L 3732, F 110, S 8, H PO 51791, I/A 1 (31.08.11).

14/09/2011 Sec. I Otros conceptos: Se modifica el artículo 4º de los Estatutos Sociales, correspondiente al domicilio social Pontevedra
Pontevedra-371297

Otros conceptos: se modifica el artículo 4º de los estatutos sociales, correspondiente al domicilio social — 14/09/2011

Otros conceptos: Se modifica el artículo 4º de los Estatutos Sociales, correspondiente al domicilio social. Datos registrales. T 3732, L 3732, F 120, S 8, H PO 51791, I/A 2 (31.08.11).

23/08/2011 Sec. I Revocaciones Ourense
Ourense-348649

Revocaciones — 23/08/2011

Revocaciones. Apoderado: MAZAIRA CASTRO ANDRES. Datos registrales. T 810 , F 70, S 8, H OR 10799, I/A 16 (29.07.11).

23/08/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-348650

Ceses/dimisiones — 23/08/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: RESGAL FERROLTERRA SL;RESGAL CORUÑA SL;CASTRO SEOANE MARIA DIGNA;SANCHEZ GORDON ROMAN;VARELA MIRAGAYA MARIA JESUS. Presidente: RESGAL FERROLTERRA SL. Secretario: SANTODOMINGO FOULQUIE IRIA....

29/03/2011 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-140789

Nombramientos — 29/03/2011

Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ GORDON ROMAN. Datos registrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 10799, I/A 15 (18.03.11).

01/02/2011 Sec. I Ampliación de capital Ourense
Ourense-43003

Ampliación de capital — 01/02/2011

Ampliación de capital. Suscrito: 8.000.000,00 Euros. Desembolsado: 8.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 18.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 18.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 1...

28/12/2010 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-482191

Nombramientos — 28/12/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ ACEVEDO ALFONSO;GUTIERREZ AMOROS MARIA DEL ROSARIO. Datos registrales. T 736 , F 66, S 8, H OR 10799, I/A 12 (17.12.10).

28/12/2010 Sec. I Revocaciones Ourense
Ourense-482192

Revocaciones — 28/12/2010

Revocaciones. Apoderado: MAZAIRA CASTRO ANDRES. Nombramientos. Apoderado: AGUILAR LOPEZ MANUEL. Datos registrales. T 810 , F 68, S 8, H OR 10799, I/A 13 (17.12.10).

16/12/2010 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-464190

Nombramientos — 16/12/2010

Nombramientos. Auditor: AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 736 , F 66, S 8, H OR 10799, I/A 11 ( 1.12.10).

11/11/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-416096

Ceses/dimisiones — 11/11/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: VAZQUEZ SACRISTAN MARIA VICTORIA;GUTIERREZ OIS JUAN MANUEL;RESGAL FERROLTERRA SL;RESGAL VIGO SL. Presidente: MATO OTERO BEATRIZ. Consejero: MATO OTERO BEATRIZ;LOPEZ ABELLA SUSANA;PIÑEIRO VAZ...

15/01/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Ourense
Ourense-14685

Ceses/dimisiones — 15/01/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: QUINTANA GONZALEZ ANXO MANUEL;LAGO VILABOA MARIA JESUS;SEARA FORMOSO XOSE BIEITO;VIÑA CARREGAL INMACULADA. Presidente: QUINTANA GONZALEZ ANXO MANUEL. Miem.Com.Ej.: SEARA FORMOSO XOSE BIEITO....

15/01/2010 Sec. I Nombramientos Ourense
Ourense-14686

Nombramientos — 15/01/2010

Nombramientos. Presidente: MATO OTERO BEATRIZ. Secretario: ORTIZ DORDA CRISTINA. Datos registrales. T 736 , F 65, S 8, H OR 10799, I/A 9 (24.12.09).

13/04/2009 Sec. I Ampliación de capital Ourense
Ourense-176028

Ampliación de capital — 13/04/2009

Ampliación de capital. Suscrito: 5.400.000,00 Euros. Desembolsado: 5.400.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 10.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 736 , F 65, S 8, H OR 1...