Actos destacados
Cambio de denominación social — 22/03/2017
Cambio de denominación social. SOCIEDAD ANONIMA DE ELECTRONICA SUBMARINA S.M.E. Datos registrales. T 3136 , F 90, S 8, H MU 3050, I/A 90 (14.03.17).
Reelecciones — 18/08/2016
Reelecciones. Consejero: ALFREDO GORDO ALVAREZ;DOMINGO CASTRO FERNANDEZ. Presidente: ALFREDO GORDO ALVAREZ. Datos registrales. T 3136 , F 90, S 8, H MU 3050, I/A 89 ( 9.08.16).
Nombramientos — 11/12/2015
Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES MAD SLP. Datos registrales. T 3136 , F 90, S 8, H MU 3050, I/A 88 ( 3.12.15).
Otros conceptos: modificación de los estatutos sociales — 02/12/2015
Otros conceptos: Modificación de los estatutos sociales. Datos registrales. T 2451 , F 88, S 8, H MU 3050, I/A 87 (25.11.15).
Reelecciones — 05/08/2015
Reelecciones. Consejero: MANUEL DE PABLO DAZA;JESUS SANCHEZ BARGOS;JEAN CLAUDE AGOSTINI. Datos registrales. T 2451 , F 88, S 8, H MU 3050, I/A 86 (29.07.15).
Reelecciones — 04/08/2014
Reelecciones. Consejero: ALFREDO GORDO ALVAREZ;DOMINGO CASTRO FERNANDEZ. Datos registrales. T 2451 , F 88, S 8, H MU 3050, I/A 85 (28.07.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 146 Lunes 4 de agosto de 2014 Pág...
Ceses/dimisiones — 18/02/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALBERTO PARRONDO ALVAREZ-INSUA;JEAN FRANCOIS GHIGNONI. Nombramientos. Consejero: JESUS SANCHEZ BARGOS;JEAN CLAUDE AGOSTINI. Datos registrales. T 2451 , F 88, S 8, H MU 3050, I/A 84 (11.02.14...
Ceses/dimisiones — 30/10/2013
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: GALAN AYUSO JORGE;GARCIA BLANCO JESUS. Revocaciones. Apo.Manc.: ANTONIO MOLINA HERNANDEZ;ALFREDO GORDO ALVAREZ;ARANZAZU SANCHEZ LOPEZ. Apo.Man.Soli: JAVIER ROMERO YACOBI. Apo.Manc.: ALEJAND...
Nombramientos — 30/10/2013
Nombramientos. Apo.Manc.: ALFREDO GORDO ALVAREZ;MANUEL DE PABLO DAZA. Datos registrales. T 2451 , F 87, S 8, H MU 3050, I/A 83 (23.10.13).
Reelecciones — 31/07/2013
Reelecciones. Consejero: JEAN FRANCOIS GHIGNONI. Datos registrales. T 2451 , F 87, S 8, H MU 3050, I/A 81 (24.07.13).
Ceses/dimisiones — 06/06/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: JAVIER ROMERO YACOBI. Nombramientos. Consejero: MANUEL DE PABLO DAZA. Datos registrales. T 2451 , F 87, S 8, H MU 3050, I/A 80 (31.05.13).
Ceses/dimisiones — 27/07/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARLOS SUAREZ PEREZ. Nombramientos. Consejero: DOMINGO CASTRO FERNANDEZ. Reelecciones. Consejero: ALFREDO GORDO ALVAREZ;ALBERTO PARRONDO ALVAREZ-INSUA. Datos registrales. T 2451 , F 86, S 8,...
Reelecciones — 04/07/2011
Reelecciones. Consejero: JAVIER ROMERO YACOBI. Datos registrales. T 2451 , F 86, S 8, H MU 3050, I/A 76 (24.06.11).
Ceses/dimisiones — 18/08/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDO GARCIA MARTINEZ PEÑALVER. Nombramientos. Consejero: CARLOS SUAREZ PEREZ. Reelecciones. Consejero: ALFREDO GORDO ALVAREZ;ALBERTO PARRONDO ALVAREZ-INSUA;PHILIPPE PORTALIER. Presidente...
Nombramientos — 07/12/2009
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2451 , F 85, S 8, H MU 3050, I/A 71 (26.11.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 233 Lunes 7 de diciembre de 2009 Pág. 70528 cve: BORME-A-2009-233-30
Reelecciones — 10/08/2009
Reelecciones. Consejero: ANTONIO FERNANDEZ SEGURA. Presidente: ANTONIO FERNANDEZ SEGURA. Datos registrales. T 2451 , F 85, S 8, H MU 3050, I/A 70 (30.07.09).