Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 13 tarjetas
10/04/2019 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-161380

Revocaciones — 10/04/2019

Revocaciones. Apoderado: DE AGUSTIN PARRA TEODORO. Datos registrales. T 37738 , F 84, S 8, H M 618581, I/A 20 ( 3.04.19).

29/03/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-142692

Nombramientos — 29/03/2019

Nombramientos. Auditor: LUQUEVELASCO AUDITORES SL. Ampliación de capital. Capital: 238.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.833.708,00 Euros. Datos registrales. T 37738 , F 83, S 8, H M 618581, I/A 19 (22.03.19).

29/01/2019 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-39777

Nombramientos — 29/01/2019

Nombramientos. Apoderado: GREGORIO MOYA JOSEFA LUCIA;ARDERIUS CARBAJAL ANA MARIA;CORTINA KOPLOWITZ PEDRO. Datos registrales. T 37738 , F 82, S 8, H M 618581, I/A 18 (21.01.19).

12/07/2018 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-290255

Ampliación de capital — 12/07/2018

Ampliación de capital. Capital: 504.755,00 Euros. Resultante Suscrito: 865.708,00 Euros. Datos registrales. T 37738 , F 79, S 8, H M 618581, I/A 15 ( 4.07.18).

28/03/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-142444

Nombramientos — 28/03/2018

Nombramientos. Auditor: LUQUE VELASCO JOSE. Datos registrales. T 34390 , F 224, S 8, H M 618581, I/A 12 (20.03.18).

15/03/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-121241

Ceses/dimisiones — 15/03/2018

Ceses/Dimisiones. Secretario: ARGALI ABOGADOS SLP. Representan: DE AGUSTIN PARRA TEODORO. Revocaciones. Apoderado: CALDERON BEDOYA GONZALO;CALDERON BEDOYA VICENTE. Apo.Man.Soli: FLEMMING BEDOYA GRACIA MARIA;CALDERON BED...

13/03/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-117000

Ceses/dimisiones — 13/03/2018

Ceses/Dimisiones. Presidente: CALDERON BEDOYA JOSE VICENTE. Consejero: CALDERON BEDOYA JOSE VICENTE;FERNANDEZ SOUTULLO DANIEL JOSE. Nombramientos. Representan: DUTILH CARVAJAL ISABEL. Consejero: JUANE SANCHEZ MIGUEL;ARG...

12/02/2018 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-67970

Ampliación de capital — 12/02/2018

Ampliación de capital. Capital: 19.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 119.048,00 Euros. Ampliación de capital. Capital: 11.905,00 Euros. Resultante Suscrito: 130.953,00 Euros. Datos registrales. T 34390 , F 221, S 8, H...

12/01/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-17192

Revocaciones — 12/01/2018

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ SOUTULLO DANIEL JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FLEMMING BEDOYA GRACIA MARIA;CALDERON BEDOYA GONZALO. Apoderado: CALDERON BEDOYA VICENTE. Datos registrales. T 34390 , F 56, S 8, H M...

16/01/2017 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-20418

Revocaciones — 16/01/2017

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ SOUTULLO DANIEL JOSE;CALDERON BEDOYA GONZALO. Apo.Manc.: CALDERON BEDOYA VICENTE. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ SOUTULLO DANIEL JOSE;CALDERON BEDOYA GONZALO;CALDERON BEDOYA VI...

28/11/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-480892

Ceses/dimisiones — 28/11/2016

Ceses/Dimisiones. Consejero: DE AGUSTIN PARRA TEODORO. Nombramientos. Representan: DE AGUSTIN PARRA TEODORO. Consejero: YOUR TELECOM SL. Datos registrales. T 34390 , F 53, S 8, H M 618581, I/A 5 (18.11.16).

28/11/2016 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-480893

Ampliación de capital — 28/11/2016

Ampliación de capital. Capital: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. Datos registrales. T 34390 , F 54, S 8, H M 618581, I/A 6 (18.11.16).

18/02/2016 Sec. I Constitución Madrid
Madrid-73851

Constitución — 18/02/2016

Constitución. Comienzo de operaciones: 3.02.16. Objeto social: gestion de red social en internet. realizacion de toda clase de actividades de marketing y desarrollo de negocio digital. Domicilio: C/ VELAZQUEZ 157 4º - P...