Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 12 tarjetas
19/04/2017 Sec. I Modificaciones estatutarias Castellón
Castellón-169805

Modificaciones estatutarias — 19/04/2017

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Modificado el Artículo 1º de los Estatutos, por cambio de la denominación social. Otros conceptos: El accionista único, a los efectos del 30/12/2016, cambia su den...

24/01/2017 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-35333

Revocaciones — 24/01/2017

Revocaciones. Apo.Manc.: SACHOT DAVID GUILLAUME JEROME;FOREST DOMINIC;MAHLER JEAN SEBASTIEN PROULX;MAHLER JEAN SEBASTIEN PROULX;SACHOT DAVID GUILLAUME JEROME;FOREST DOMINIC. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 15, S 8,...

24/01/2017 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-35334

Nombramientos — 24/01/2017

Nombramientos. Apo.Manc.: FERRE SANDRINE BERNADETTE MADELEINE. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 15, S 8, H CS 36557, I/A 12 (17.01.17).

21/10/2016 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-424432

Revocaciones — 21/10/2016

Revocaciones. Apo.Manc.: RAYNAUD ALAIN PIERRE;RAYNAUD ALAIN PIERRE. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 14, S 8, H CS 36557, I/A 10 (10.10.16).

11/07/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Castellón
Castellón-288657

Ceses/dimisiones — 11/07/2016

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VAZQUEZ PARDO CONSTANTINO CESAR. VsecrNoConsj: ESTEBAN GARCIA-BERNALT CARMEN. Nombramientos. SecreNoConsj: ESTEBAN GARCIA-BERNALT CARMEN. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 14, S 8, H C...

08/07/2015 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-279807

Revocaciones — 08/07/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: BASSO JEAN MICHEL;BASSO JEAN MICHEL. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 14, S 8, H CS 36557, I/A 7 (30.06.15).

02/07/2015 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-271559

Nombramientos — 02/07/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: RUOZ DANIEL CHARLES. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 14, S 8, H CS 36557, I/A 6 (23.06.15).

07/05/2015 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-186454

Nombramientos — 07/05/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: MAINI EDDY ENRICO BERNARDO;MAHLER JEAN SEBASTIEN PROULX;BASSO JEAN MICHEL;SACHOT DAVID GUILLAUME JEROME;COURIET-BOSSAN DE GARAGNOR ROMAIN MARIE MICHEL;COUSIN BENOIT MARTIAL SYLVAIN;FOREST DOMIN...

06/04/2015 Sec. I Revocaciones Castellón
Castellón-141308

Revocaciones — 06/04/2015

Revocaciones. Apo.Manc.: MAINI EDDY ENRICO BERNARDO. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 13, S 8, H CS 36557, I/A 3 (26.03.15).

06/04/2015 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-141309

Nombramientos — 06/04/2015

Nombramientos. Apo.Manc.: EL MOUDDEN MOHAMED. Datos registrales. T 1649, L 1211, F 13, S 8, H CS 36557, I/A 4 (26.03.15).

25/11/2014 Sec. I Nombramientos Castellón
Castellón-479516

Nombramientos — 25/11/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: MAINI EDDY ENRICO BERNARDO;BASSO JEAN MICHEL;SACHOT DAVID GUILLAUME JEROME;COURIET-BOSSAN DE GARAGNOR ROMAIN MARIE MICHEL;COUSIN BENOIT MARTIAL SYLVAIN;FOREST DOMINIC;RAYNAUD ALAIN PIERRE;DI LI...

03/06/2014 Sec. I Constitución Castellón
Castellón-232181

Constitución — 03/06/2014

Constitución. Comienzo de operaciones: 19.05.14. Objeto social: La explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones aeroportuarias del Aeropuerto de Castellón Costa Azahar como Gestor Aeroportuario, presta...