Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 5 tarjetas
05/01/2016 Sec. I Modificaciones estatutarias Madrid
Madrid-2714

Modificaciones estatutarias — 05/01/2016

Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, CREACION DEL ARTICULO 1 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. . Cambio de denominación social. SHERPA CAPITAL ENTIDAD GESTORA SOCIEDAD GESTORA...

22/12/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-518105

Ceses/dimisiones — 22/12/2015

Ceses/Dimisiones. Representan: GRANELL BALLESTER JUAN RAMON. Consejero: 4PROY M&C SL. Nombramientos. Representan: BESCHINSKY CORTAZAR JORGE. Consejero: SHERPA DESARROLLO SL. Datos registrales. T 30651 , F 79, S 8, H M 5...

20/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-298018

Nombramientos — 20/07/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: PINEDO MENDIZABAL RAFAEL;FERNANDEZ MIRET JORGE. Datos registrales. T 30651 , F 78, S 8, H M 551559, I/A 10 (10.07.15).

09/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-281807

Nombramientos — 09/07/2015

Nombramientos. Apoderado: BRU TABERNERO ALFREDO. Datos registrales. T 30651 , F 75, S 8, H M 551559, I/A 8 (30.06.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 128 Jueves 9 de julio de 2015 Pág. 30471 cve: BORME-A-20...

09/07/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-281808

Nombramientos — 09/07/2015

Nombramientos. Apoderado: GRANELL BALLESTER JUAN RAMON. Datos registrales. T 30651 , F 78, S 8, H M 551559, I/A 9 (30.06.15).