Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 24 tarjetas
08/02/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-63623

Ceses/dimisiones — 08/02/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: EMMANUELLE CAMUS NIKITINE. Presidente: SUDAN ASHOK. Nombramientos. Consejero: DIMITRI JEAN MARIE DUMESTRE. Presidente: THOMAS RIOU. Datos registrales. T 283 , F 133, S 8, H SG 2018, I/A 102...

08/02/2017 Sec. I Cambio de denominación social Segovia
Segovia-63624

Cambio de denominación social — 08/02/2017

Cambio de denominación social. VERESCENCE LA GRANJA SL. Datos registrales. T 283 , F 133, S 8, H SG 2018, I/A 103 ( 1.02.17).

08/03/2016 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-109522

Ceses/dimisiones — 08/03/2016

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LEIS MAYAN LUIS ANTONIO. Revocaciones. Apo.Man.Soli: USTERO ALONSO JOSE LUIS;LOPEZ SANCHEZ, MARIO CESAR. Nombramientos. SecreNoConsj: ANGEL JOSE MARCOS DURANTEZ. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCH...

05/01/2016 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-3052

Nombramientos — 05/01/2016

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 283 , F 130, S 8, H SG 2018, I/A 100 (28.12.15).

21/05/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-204939

Ceses/dimisiones — 21/05/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: BRUNET FREDERIC. Nombramientos. Consejero: EMMANUELLE CAMUS NIKITINE. Datos registrales. T 283 , F 130, S 8, H SG 2018, I/A 99 (13.05.15).

14/04/2015 Sec. I Revocaciones Segovia
Segovia-153843

Revocaciones — 14/04/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALVAREZ, BENJAMIN;FERNANDEZ GOMEZ, JOSE. Apo.Sol.: MARCOS JAVIER ARRANZ MOLINS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRANCISCO DE BORJA SANCHIS CIENFUEGOS-JOVELLANOS;PABLO ROMAN GARCIA;MARCO...

15/01/2015 Sec. I Reducción de capital Segovia
Segovia-14585

Reducción de capital — 15/01/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 6.055.550,00 Euros. Resultante Suscrito: 27.000.000,00 Euros. Otros conceptos: MODIFICACION DEL NUMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIONES SOCIALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA DIVIDID...

21/03/2014 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-129621

Nombramientos — 21/03/2014

Nombramientos. Apo.Sol.: MARCOS JAVIER ARRANZ MOLINS. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALVAREZ, BENJAMIN;FERNANDEZ GOMEZ, JOSE. Datos registrales. T 283 , F 126, S 8, H SG 2018, I/A 94 (12.03.14).

21/03/2014 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-129622

Nombramientos — 21/03/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ, MARIO CESAR;USTERO ALONSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 283 , F 127, S 8, H SG 2018, I/A 95 (12.03.14).

19/03/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-125217

Ceses/dimisiones — 19/03/2014

Ceses/Dimisiones. Consejero: SHAN DAVID. Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ, MARIO CESAR;USTERO ALONSO JOSE LUIS;AZPIROZ QUESADA, DOLORES;FERNANDEZ GOMEZ, JOSE. Apo.Sol.: GUTIERREZ SOLANA SABRINA. Apo.Man.Soli: M...

19/03/2014 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-125218

Nombramientos — 19/03/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: AZPIROZ QUESADA, DOLORES;JESUS OLIVER SAEZ. Datos registrales. T 283 , F 121, S 8, H SG 2018, I/A 92 (12.03.14).

19/03/2014 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-125219

Nombramientos — 19/03/2014

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREDERIC GUILLOTOU KEREVER;ELIAS PY RODRIGUEZ. Datos registrales. T 283 , F 125, S 8, H SG 2018, I/A 93 (12.03.14).

26/03/2013 Sec. I Reelecciones Segovia
Segovia-146589

Reelecciones — 26/03/2013

Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 158 , F 109, S 8, H SG 2018, I/A 90 (19.03.13).

08/01/2013 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-7632

Nombramientos — 08/01/2013

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 158 , F 109, S 8, H SG 2018, I/A 89 (28.12.12).

03/10/2012 Sec. I Revocaciones Segovia
Segovia-403853

Revocaciones — 03/10/2012

Revocaciones. Apoderado: JARABA MUÑOZ, LUIS FERNANDO;BENAVIDES ABAJO, JOAQUIN;MARTINEZ ALVAREZ, BENJAMIN;ANDRES ARRANZ LUIS. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ GOMEZ, JOSE;CARRICAJO MAZARIEGOS, DOMINGO. Apoderado: AZPIROZ QUESADA,...

29/08/2012 Sec. I Revocaciones Segovia
Segovia-359296

Revocaciones — 29/08/2012

Revocaciones. Apo.Man.Soli: USTERO SANCHEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: USTERO ALONSO JOSE LUIS. Datos registrales. T 158 , F 107, S 8, H SG 2018, I/A 87 (21.08.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm...

19/07/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-305863

Ceses/dimisiones — 19/07/2012

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DE ANDRES ARRANZ LUIS ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: LEIS MAYAN, LUIS ANTONIO. Apo.Man.Soli: LOPEZ SANCHEZ, MARIO CESAR;USTERO SANCHEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 158 , F 106,...

28/09/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-388424

Ceses/dimisiones — 28/09/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: FREDERIC SINNAH RAYMOND. Nombramientos. Consejero: SHAN, DAVID. Datos registrales. T 158 , F 106, S 8, H SG 2018, I/A 85 ( 8.09.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 185 Miércoles...

18/04/2011 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-173266

Nombramientos — 18/04/2011

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ MARIO CESAR. Datos registrales. T 158 , F 105, S 8, H SG 2018, I/A 83 ( 7.04.11).

18/04/2011 Sec. I Revocaciones Segovia
Segovia-173267

Revocaciones — 18/04/2011

Revocaciones. Apo.Man.Soli: JIMENEZ NUÑEZ JOSE ENRIQUE;FRANCISCO MANUEL HURTADO MARJALIZO. Apoderado: FRANCISCO MANUEL HURTADO MARJALIZO. Datos registrales. T 158 , F 105, S 8, H SG 2018, I/A 84 ( 7.04.11).

27/01/2011 Sec. I Nombramientos Segovia
Segovia-35304

Nombramientos — 27/01/2011

Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 158 , F 105, S 8, H SG 2018, I/A 82 (18.01.11).

29/12/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-484283

Ceses/dimisiones — 29/12/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: DUBOC JEAN-MARIE. SecreNoConsj: FRANCISCO MANUEL HURTADO MARJALIZO. Nombramientos. Consejero: BRUNET FREDERIC. SecreNoConsj: DE ANDRES ARRANZ LUIS ANTONIO. Datos registrales. T 158 , F 105,...

28/10/2010 Sec. I Ceses/Dimisiones Segovia
Segovia-400300

Ceses/dimisiones — 28/10/2010

Ceses/Dimisiones. Consejero: DILLARD THIERRY. Presidente: DILLARD THIERRY. Nombramientos. Consejero: SUDAN ASHOK. Presidente: SUDAN ASHOK. Datos registrales. T 158 , F 104, S 8, H SG 2018, I/A 80 ( 8.10.10).

31/05/2010 Sec. I Revocaciones Segovia
Segovia-217199

Revocaciones — 31/05/2010

Revocaciones. Apoderado: JEAN PIERRE FLORIS;JIMENEZ HERAS ANTONIO JULIAN;CLAUDE IMAUVEN. Apo.Man.Soli: JIMENEZ HERAS ANTONIO;ROSARIO PAYO VICENTE. Apoderado: CEÑAL BERJANO RAMON;JESUS PASTOR MINGUEZ;MARIA CRUZ RUBIO GAR...