Actos destacados
Revocaciones — 13/06/2017
Revocaciones. Apoderado: GUTIERREZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 728, L 519, F 197, S 8, H BU 9571, I/A 16 ( 7.06.17).
Nombramientos — 15/03/2017
Nombramientos. Apoderado: SANTAMARINA DURAN JAVIER. Datos registrales. T 493, L 284, F 18, S 8, H BU 9571, I/A 15 ( 8.03.17).
Nombramientos — 16/02/2015
Nombramientos. Apo.Manc.: LAZARO ORDOÑEZ MERCEDES;LLORENTE HERRERO MARTA. Datos registrales. T 493, L 284, F 18, S 8, H BU 9571, I/A 14 (10.02.15).
Revocaciones — 08/01/2015
Revocaciones. Apoderado: ARNAIZ LOZARES MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 493, L 284, F 18, S 8, H BU 9571, I/A 13 (30.12.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 4 Jueves 8 de enero de 2015 Pág. 371 cve: BORME...
Revocaciones — 26/12/2012
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ REVUELTA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 493, L 284, F 18, S 8, H BU 9571, I/A 12 (18.12.12).
Nombramientos — 11/06/2012
Nombramientos. Apoderado: CODON CANO MARIA. Datos registrales. T 493, L 284, F 18, S 8, H BU 9571, I/A 11 (31.05.12).
Nombramientos — 09/12/2011
Nombramientos. Apoderado: BLANCO NIETO MARINA. Datos registrales. T 493, L 284, F 17, S 8, H BU 9571, I/A 10 (29.11.11).
Revocaciones — 05/09/2011
Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ BONILLA EDUARDO. Datos registrales. T 493, L 284, F 17, S 8, H BU 9571, I/A 9 (25.08.11).
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 493, L 284, F 17, S 8, H BU 9571, I/A 7 (31.03.11).
Nombramientos — 11/04/2011
Nombramientos. Apoderado: SANTAMARIA DURAN JAVIER. Datos registrales. T 493, L 284, F 17, S 8, H BU 9571, I/A 8 (31.03.11).