Actos destacados
Ceses/dimisiones — 30/07/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: HAFELE ULRICH;MICHEL JURG;RAMIREZ CODINA JUAN;WINDRICH BERNHARD. Presidente: HAFELE ULRICH. Con.Delegado: MICHEL JURG. Secretario: RAMIREZ CODINA JUAN. Nombramientos. Consejero: WEBER RONALD...
Otros conceptos: modificacion de los articulos 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, el titulo vii pasa a denominarse "regimen supletorio", y supresion del 14, 18, 26 y disposic — 30/07/2013
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, EL TITULO VII PASA A DENOMINARSE "REGIMEN SUPLETORIO", Y SUPRESION DEL 14, 18, 26 Y DISPOSIC. ADICION...
Cambio de domicilio social — 22/03/2013
Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL PAGATXA, PARCELA 9, S/N. (ELGETA). Datos registrales. T 2596 , F 1, S 8, H SS 35231, I/A 1 (13.03.13).
Nombramientos — 22/03/2013
Nombramientos. Apoderado: WALTER CHRISTOPH. Datos registrales. T 2596 , F 10, S 8, H SS 35231, I/A 3 (14.03.13).
Nombramientos — 22/03/2013
Nombramientos. Apo.Sol.: RUTES BANDE JOSE MARIA;URQUIJO MUGICA EDUARDO. Datos registrales. T 2596 , F 10, S 8, H SS 35231, I/A 4 (14.03.13).
Disolución — 27/11/2009
Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 7496, L 4797, F 135, S 8, H V 90200, I/ACANCE (18.11.09).
Sociedad unipersonal — 24/06/2009
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: WURTH INTERNATIONAL AG. Datos registrales. T 7496, L 4797, F 135, S 8, H V 90200, I/A 10 (15.06.09).