Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2013 5 tarjetas
02/01/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-333

Nombramientos — 02/01/2013

Nombramientos. Apoderado: SOLER DEL RIO LLUIS. Datos registrales. T 28497 , F 150, S 8, H M 301219, I/A 61 (17.12.12).

20/09/2012 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-384569

Revocaciones — 20/09/2012

Revocaciones. Apoderado: SOLER DEL RIO LLUIS;PLANAS SACRISTAN ALFONSO;CONESA GALLI LUIS;RISUEÑO ALTIER JORGE;PLANAS SACRISTAN ALFONSO. Datos registrales. T 28497 , F 148, S 8, H M 301219, I/A 58 (10.09.12).

03/04/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-153058

Nombramientos — 03/04/2012

Nombramientos. Apoderado: YARZA PEREZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 28497 , F 144, S 8, H M 301219, I/A 51 (22.03.12). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 65 Martes 3 de abril de 2012 Pág. 16604 cve: BORME-A...

03/04/2012 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-153059

Nombramientos — 03/04/2012

Nombramientos. Apoderado: CASTELLS CRUZADO JAVIER. Datos registrales. T 28497 , F 145, S 8, H M 301219, I/A 52 (22.03.12).

23/12/2009 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-533626

Nombramientos — 23/12/2009

Nombramientos. Apoderado: PLANAS SACRISTAN ALFONSO. Datos registrales. T 17529 , F 224, S 8, H M 301219, I/A 38 (11.12.09).