Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2018 12 tarjetas
13/06/2018 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-248842

Cambio de denominación social — 13/06/2018

Cambio de denominación social. INV COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES SL. Datos registrales. T 25921 , F 116, S 8, H M 47282, I/A 134 ( 6.06.18). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 112 Miércoles 13 de junio de 20...

23/05/2018 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-218169

Revocaciones — 23/05/2018

Revocaciones. Apoderado: ESTEBAN AZNAR ALEJANDRO;OSQUILA URIARTE ROBERTO. Apo.Sol.: MORENO MAIZ FERNANDO. Apoderado: MUÑOZ SANCHEZ SANTOS TOMAS;MARTIN ESPINOSA ANA MARIA;GIL SEGURA ALMUDENA. Apo.Sol.: BARRON MIÑAMBRES M...

10/04/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-157636

Nombramientos — 10/04/2018

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CRUZ ALBERTO;ANTONIO ZARZOSO CARTAGENA. Datos registrales. T 25921 , F 114, S 8, H M 47282, I/A 132 ( 3.04.18).

12/03/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-114645

Ceses/dimisiones — 12/03/2018

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DE ORIOL E ICAZA MONICA. Nombramientos. Adm. Unico: RODRIGUEZ MUÑOZ JESUS FRANCISCO. Datos registrales. T 25921 , F 114, S 8, H M 47282, I/A 131 ( 1.03.18).

16/02/2018 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-78345

Nombramientos — 16/02/2018

Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MUÑOZ JESUS FRANCISCO. Datos registrales. T 25921 , F 112, S 8, H M 47282, I/A 130 ( 9.02.18).

27/07/2017 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-309428

Reelecciones — 27/07/2017

Reelecciones. Auditor: VALLDAURA Y ASOCIADOS SL. Datos registrales. T 25921 , F 112, S 8, H M 47282, I/A 129 (19.07.17).

19/06/2017 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-252860

Nombramientos — 19/06/2017

Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GADEA ANTONIO. Datos registrales. T 25921 , F 112, S 8, H M 47282, I/A 128 ( 9.06.17).

25/09/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-389141

Cambio de domicilio social — 25/09/2015

Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 9 - 1& PLANTA (MADRID). Datos registrales. T 25921 , F 111, S 8, H M 47282, I/A 124 (17.09.15).

16/03/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-112325

Revocaciones — 16/03/2015

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ DE GUINEA LUIS MANUEL;DE LA CRUZ MUÑOZ SONIA;BLANCO PRIMO SAGRARIO. Apo.Man.Soli: IMAZ RUBALCABA JAVIER. Apoderado: ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS. Apo.Man.Soli: LORENZO TORETS ANA. Datos regis...

23/09/2014 Sec. I Ampliación de capital Madrid
Madrid-377863

Ampliación de capital — 23/09/2014

Ampliación de capital. Capital: 3.786,30 Euros. Resultante Suscrito: 9.796,30 Euros. Datos registrales. T 25921 , F 107, S 8, H M 47282, I/A 119 (12.09.14).

31/01/2014 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-46259

Nombramientos — 31/01/2014

Nombramientos. Apoderado: ZAYAS SATRUSTEGUI LUIS. Apo.Manc.: DE ORIOL E ICAZA MONICA;IMAZ RUBALCABA JAVIER. Datos registrales. T 25921 , F 102, S 8, H M 47282, I/A 113 (23.01.14). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL...

30/12/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-556325

Nombramientos — 30/12/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: DE ORIOL E ICAZA MONICA. Apo.Man.Soli: IMAZ RUBALCABA JAVIER. Datos registrales. T 25921 , F 100, S 8, H M 47282, I/A 112 (19.12.13).