Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 23 tarjetas
23/02/2016 Sec. I Cambio de denominación social Madrid
Madrid-81252

Cambio de denominación social — 23/02/2016

Cambio de denominación social. BEAUTY BY DIA SA. Datos registrales. T 30918 , F 104, S 8, H M 556468, I/A 16 (12.02.16).

05/02/2016 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-52643

Nombramientos — 05/02/2016

Nombramientos. Apo.Sol.: RICO SANTIAGO OLGA. Datos registrales. T 30918 , F 103, S 8, H M 556468, I/A 15 (28.01.16).

20/11/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-470676

Nombramientos — 20/11/2015

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CONTIN ALBERTO. Datos registrales. T 30918 , F 98, S 8, H M 556468, I/A 13 (13.11.15).

09/09/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-368485

Revocaciones — 09/09/2015

Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIAZ RENOVALES ELIAS. Apo.Sol.: MARTI SANCHO ALEX. Apo.Manc.: MARTI SANCHO ALEX. Apo.Man.Soli: ALONSO CARRERAS JOSE LUIS. Apo.Manc.: RESCALVO GARCIA DE LA BARGA ALVARO;ALONSO CARRERAS JOSE LU...

05/02/2014 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-53496

Ceses/dimisiones — 05/02/2014

Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 30918 , F 80, S 8, H M 556468, I/A 6 (28.01.14).

08/10/2013 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-430651

Nombramientos — 08/10/2013

Nombramientos. Apoderado: JIMENEZ PALOMO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 30918 , F 79, S 8, H M 556468, I/A 4 (30.09.13).

20/03/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Tarragona
Tarragona-133613

Ceses/dimisiones — 20/03/2013

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZUBER JOHANNES. Revocaciones. Apo.Sol.: METZGER ROMY;MACHREICH HANS-JOACHIM. Nombramientos. Consejero: ARNANZ MARTIN ANTONIO;IGLESIAS PEINADO MIGUEL ANGEL;CAVESTANY DE DALMASES DIEGO.Presid...

20/03/2013 Sec. I Nombramientos Tarragona
Tarragona-133614

Nombramientos — 20/03/2013

Nombramientos. Apo.Man.Soli: AGUSTIN MARTIN JUAN PEDRO;ALBENDEA SAN JUAN FRANCISCO JAVIER;ALONSO CARRERAS JOSE LUIS;ALVAREZ BADIOLA NEREA;ALVAREZ FERNANDEZ RAUL;ALVAREZ LORA JESUS;ALVAREZ NIETO MARIA NIEVES;ALVAREZ OLAL...

20/03/2013 Sec. I Nombramientos Tarragona
Tarragona-133615

Nombramientos — 20/03/2013

Nombramientos. Apoderado: IGLESIAS PEINADO MIGUEL ANGEL;ARNANZ MARTIN ANTONIO. Datos registrales. T 2728 , F 64, S 8, H T 2120, I/A 72 ( 5.03.13). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 54 Miércoles 20 de marzo de...

20/03/2013 Sec. I Sociedad unipersonal Tarragona
Tarragona-133616

Sociedad unipersonal — 20/03/2013

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SOCIED. Datos registrales. T 2728 , F 65, S 8, H T 2120, I/A 73 ( 5.03.13).

22/01/2013 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Tarragona
Tarragona-32197

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 22/01/2013

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L. Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 2703 , F 190, S 8...

26/12/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Tarragona
Tarragona-537964

Ceses/dimisiones — 26/12/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BREYER MARCUS. Nombramientos. Adm. Unico: ZUBER JOHANNES. Datos registrales. T 2703 , F 190, S 8, H T 2120, I/A 67 (18.12.12).

26/12/2012 Sec. I Declaración de unipersonalidad Tarragona
Tarragona-537965

Declaración de unipersonalidad — 26/12/2012

Declaración de unipersonalidad. Socio único: SCHLECKER INTERNATIONAL GMBH. Datos registrales. T 2703 , F 190, S 8, H T 2120, I/A 68 (18.12.12).

09/10/2012 Sec. I Nombramientos Tarragona
Tarragona-412680

Nombramientos — 09/10/2012

Nombramientos. Apo.Sol.: METZGER ROMY;MACHREICH HANS-JOACHIM. Datos registrales. T 2701 , F 27, S 8, H T 2120, I/A 66 (19.09.12).

13/09/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Tarragona
Tarragona-376514

Ceses/dimisiones — 13/09/2012

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BALAÑA POOCH ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: BREYER MARCUS. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 64 (28.08.12).

13/09/2012 Sec. I Nombramientos Tarragona
Tarragona-376515

Nombramientos — 13/09/2012

Nombramientos. Apoderado: BALAÑA POOCH ANTONIO. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 65 (28.08.12).

20/07/2012 Sec. I Revocaciones Tarragona
Tarragona-307989

Revocaciones — 20/07/2012

Revocaciones. Apoderado: JENTER GUNTHER. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 62 (11.07.12).

20/07/2012 Sec. I Revocaciones Tarragona
Tarragona-307990

Revocaciones — 20/07/2012

Revocaciones. Apoderado: SCHLECKER ANTON. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 63 (11.07.12).

09/05/2012 Sec. I Otros conceptos: Con fecha 27 de marzo de 2 Tarragona
Tarragona-199167

Otros conceptos: con fecha 27 de marzo de 2 — 09/05/2012

Otros conceptos: Con fecha 27 de marzo de 2.012 La Sociedad ha puesto para la emisión y puesta en circulación de los títulos representativos de las acciones que representan el Capital social. Datos registrales. T 1060 ,...

13/04/2012 Sec. I Reelecciones Tarragona
Tarragona-167094

Reelecciones — 13/04/2012

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 61 (29.03.12).

27/01/2011 Sec. I Reelecciones Tarragona
Tarragona-35379

Reelecciones — 27/01/2011

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG ABOGADOS S.L. Datos registrales. T 1060 , F 147, S 8, H T 2120, I/A 60 (17.01.11).

12/01/2010 Sec. I Nombramientos Tarragona
Tarragona-10630

Nombramientos — 12/01/2010

Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG S.L. Datos registrales. T 1060 , F 146, S 8, H T 2120, I/A 59 (24.12.09).

11/09/2009 Sec. I Revocaciones Tarragona
Tarragona-393091

Revocaciones — 11/09/2009

Revocaciones. Apoderado: FREUDENREICH REINHOLD ANTON. Datos registrales. T 1060 , F 146, S 8, H T 2120, I/A 58 ( 2.09.09).