Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 5 tarjetas
29/03/2017 Sec. I Extinción Madrid
Madrid-141063

Extinción — 29/03/2017

Extinción. Datos registrales. T 14326 , F 59, S 8, H M 236388, I/A 1M (24.10.16).

03/07/2015 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-274078

Cambio de domicilio social — 03/07/2015

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 7 (MADRID). Datos registrales. T 29954 , F 58, S 8, H M 236388, I/A 9 (26.06.15).

08/07/2014 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-280831

Reelecciones — 08/07/2014

Reelecciones. Consejero: RIVERO GARCIA MIGUEL ANGEL. Presidente: RIVERO GARCIA MIGUEL ANGEL. Con.Delegado: RIVERO GARCIA MIGUEL ANGEL. Consejero: SANCHEZ SCHAELCHLI SOLEDAD PALOMA. Datos registrales. T 29954 , F 57, S 8...

23/08/2013 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-374870

Revocaciones — 23/08/2013

Revocaciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 29954 , F 57, S 8, H M 236388, I/A 7 (14.08.13).

13/04/2012 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-165785

Revocaciones — 13/04/2012

Revocaciones. CONSEJERO: GARCIA NIETO PORTABELLA IGNACIO. SECRETARIO: GARCIA NIETO PORTABELLA IGNACIO. Nombramientos. SECR.NO CONS: LLAVE ALONSO LOURDES. Datos registrales. T 33950 , F 160, S 8, H B 240176, I/A 21 ( 2.0...