Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2014 5 tarjetas
17/03/2014 Sec. I Otros conceptos: Cerrada la hoja por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil Zaragoza
Zaragoza-120350

Otros conceptos: cerrada la hoja por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del reglamento del registro mercantil — 17/03/2014

Otros conceptos: Cerrada la hoja por plazo provisional de 6 meses, conforme al artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil. Datos registrales. T 3163 , F 28, S 8, H Z 25437, I/A 43 F (10.03.14). http://www.boe.es...

09/04/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-166785

Nombramientos — 09/04/2013

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ BALMON ROSARIO;MATEO LOPEZ JUAN. Apo.Manc.: MATEO LOPEZ JUAN. Apo.Sol.: LASIERRA MARCO JORGE. Apo.Manc.: LASIERRA MARCO JORGE. Datos registrales. T 3163 , F 27, S 8, H Z 25437, I/A 41...

09/04/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-166786

Nombramientos — 09/04/2013

Nombramientos. Apo.Manc.: LASIERRA MARCO JORGE;MATEO LOPEZ JUAN;SOLER LOPEZ TERESA;PEREZ DIAZ ENRIQUE. Datos registrales. T 3163 , F 28, S 8, H Z 25437, I/A 42 ( 1.04.13).

09/04/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-166787

Nombramientos — 09/04/2013

Nombramientos. Apoderado: SEGURA TOMAS MARIA DE LAS MERCEDES. Datos registrales. T 3163 , F 28, S 8, H Z 25437, I/A 43 ( 1.04.13).

13/06/2012 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-250027

Ceses/dimisiones — 13/06/2012

Ceses/Dimisiones. Presidente: VAN DER LAAN ANTONIUS THEODORUS CHRISTOFFEL. Consejero: VAN DER LAAN ANTONIUS THEODORUS CHRISTOFFEL. Nombramientos. Consejero: PEREZ DIAZ ENRIQUE. Presidente: PEREZ DIAZ ENRIQUE. Datos regi...