Actos destacados
Ceses/dimisiones — 28/06/2019
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GOMEZ LECHON SERRANO FEDERICO. Nombramientos. Vicepresid.: SANCHEZ CASTAÑO FERNANDO. Reelecciones. Secretario: DIAZ PARDO RICARDO. Consejero: SANCHEZ GARCIA FERNANDO;SANCHEZ CASTAÑO FERNAN...
Reelecciones — 07/02/2018
Reelecciones. Auditor: A1 & GAVIA AUVAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 154, S 8, H V 21367, I/A 41 (31.01.18).
Reducción de capital — 24/01/2018
Reducción de capital. Importe reducción: 96.161,60 Euros. Resultante Suscrito: 504.848,40 Euros. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 154, S 8, H V 21367, I/A 40 (17.01.18).
Nombramientos — 18/02/2015
Nombramientos. Auditor: A1 & GAVIA AUVAL AUDITORES SLPU. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 154, S 8, H V 21367, I/A 39 (11.02.15).
Ceses/dimisiones — 01/10/2014
Ceses/Dimisiones. Secretario: DIAZ PARDO RICARDO. Consejero: SANCHEZ GARCIA FERNANDO;SANCHEZ CASTAÑO FERNANDO;GOMEZ LECHON SERRANO FEDERICO;NAVARRO VILAR JOSE LUIS. Presidente: SANCHEZ GARCIA FERNANDO. Vicepresid.: GOME...
Nombramientos — 22/01/2014
Nombramientos. Cons.Del.Sol: SANCHEZ CASTAÑO FERNANDO;GOMEZ LECHON SERRANO FEDERICO;NAVARRO VILAR JOSE LUIS. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 153, S 8, H V 21367, I/A 37 (15.01.14).
Nombramientos — 03/04/2012
Nombramientos. Auditor: GAVIA AUVAL AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 152, S 8, H V 21367, I/A 35 (23.03.12).
Reelecciones — 25/05/2011
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 152, S 8, H V 21367, I/A 34 (16.05.11).
Reelecciones — 20/04/2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4276, L 1588, F 152, S 8, H V 21367, I/A 32 ( 9.04.10).
Ceses/dimisiones — 03/03/2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ GARCIA FERNANDO;CASTAÑO CASANOVA MARIA GLORIA;SANCHEZ CASTAÑO FERNANDO;SANCHEZ CASTAÑO RAQUEL;SANCHEZ CASTAÑO GLORIA PATRICIA. Presidente: SANCHEZ GARCIA FERNANDO. Secretario: SANCHE...