Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2015 6 tarjetas
16/09/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Madrid
Madrid-377583

Ceses/dimisiones — 16/09/2015

Ceses/Dimisiones. Consejero: HERRERA AGUDO JUAN PABLO;RAMIREZ LOPEZ TERRADAS ALVARO. Presidente: RAMIREZ LOPEZ TERRADAS ALVARO. Secretario: HERRERA AGUDO JUAN PABLO. Consejero: VERNIERE FABRICE LIONEL LEONCE. Con.Delega...

25/08/2015 Sec. I Revocaciones Madrid
Madrid-350693

Revocaciones — 25/08/2015

Revocaciones. Apoderado: GALDEANO BONEL ALEXANDRE. Datos registrales. T 28483 , F 137, S 8, H M 33033, I/A 53 (14.08.15). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 161 Martes 25 de agosto de 2015 Pág. 37823 cve: BORME...

15/06/2015 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-241134

Nombramientos — 15/06/2015

Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 28483 , F 137, S 8, H M 33033, I/A 52 ( 5.06.15).

08/11/2012 Sec. I Cambio de domicilio social Madrid
Madrid-459421

Cambio de domicilio social — 08/11/2012

Cambio de domicilio social. C/ LABASTIDA 10-12 (MADRID). Datos registrales. T 28483 , F 133, S 8, H M 33033, I/A 43 (26.10.12).

22/10/2012 Sec. I Reelecciones Madrid
Madrid-428338

Reelecciones — 22/10/2012

Reelecciones. Consejero: RAMIREZ LOPEZ TERRADAS ALVARO. Presidente: RAMIREZ LOPEZ TERRADAS ALVARO. Con.Delegado: RAMIREZ LOPEZ TERRADAS ALVARO. Secretario: HERRERA AGUDO JUAN PABLO. Datos registrales. T 28483 , F 132, S...

09/12/2011 Sec. I Nombramientos Madrid
Madrid-489962

Nombramientos — 09/12/2011

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PARDO CESPEDES LUIS. Datos registrales. T 28483 , F 130, S 8, H M 33033, I/A 39 (25.11.11).