Actos destacados
Extinción — 06/03/2015
Extinción. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 27 (16.02.15).
Ceses/dimisiones — 23/02/2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LLORENTE MUÑOZ PATRICIO. Nombramientos. Liquidador: CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE SA. Disolución. Voluntaria. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 27 (16.02.15).
Revocaciones — 07/05/2013
Revocaciones. Apoderado: IZARRA DE LA CRUZ CARLOS. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 26 (25.04.13).
Revocaciones — 16/07/2012
Revocaciones. Apoderado: GUERRA LOPEZ ALBERTO. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 25 ( 5.07.12).
Revocaciones — 28/03/2012
Revocaciones. Apoderado: HOSPITAL GARCIA AGUSTIN;HOSPITAL GARCIA AGUSTIN. Apo.Sol.: HOSPITAL GARCIA AGUSTIN. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 24 (15.03.12).
Reelecciones — 30/11/2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 1476 , F 27, S 8, H TO 30264, I/A 23 (21.11.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 227 Miércoles 30 de noviembre de 2011 Pág. 67828 cve: BORME-A-2011-22...
Nombramientos — 03/08/2011
Nombramientos. Apoderado: IZARRA DE LA CRUZ CARLOS. Datos registrales. T 1476 , F 26, S 8, H TO 30264, I/A 22 (20.07.11).
Revocaciones — 29/04/2011
Revocaciones. Apoderado: TORRES ALONSO LUIS;TORRES ALONSO LUIS;TORRES ALONSO LUIS. Datos registrales. T 1476 , F 26, S 8, H TO 30264, I/A 21 (18.04.11).
Nombramientos — 15/03/2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTIN GARCIA NOE. Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 19 ( 3.03.11).
Nombramientos — 15/03/2011
Nombramientos. Apoderado: BIOSQUEZ CUADROS CARLOS. Datos registrales. T 1476 , F 25, S 8, H TO 30264, I/A 20 ( 3.03.11).
Revocaciones — 18/02/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: QUINTANAL HIGUERA ALVARO. Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 18 ( 7.02.11).
Revocaciones — 04/10/2010
Revocaciones. Apoderado: MADRID IZQUIERDO ENRIQUE;MADRID IZQUIERDO ENRIQUE. Apo.Sol.: MADRID IZQUIERDO ENRIQUE. Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 17 (23.09.10).
Cambio de domicilio social — 14/12/2009
Cambio de domicilio social. C/ ITALIA 113 (TOLEDO). Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 16 (30.11.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: HOSPITAL GARCIA AGUSTIN. Datos registrales. T 1466 , F 68, S 8, H TO 30264, I/A 6 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: PEREZ CASADO JAVIER. Datos registrales. T 1466 , F 69, S 8, H TO 30264, I/A 7 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: MADRID IZQUIERDO ENRIQUE. Datos registrales. T 1476 , F 20, S 8, H TO 30264, I/A 8 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PELAEZ BOCOS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 1476 , F 21, S 8, H TO 30264, I/A 9 (16.07.09). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 142 Miércoles 29 de julio de 2009 Pág. 38974 cve:...
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MOURE SORIA JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1476 , F 21, S 8, H TO 30264, I/A 10 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCO RODRIGUEZ DAVID. Datos registrales. T 1476 , F 22, S 8, H TO 30264, I/A 11 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: FRAILE HERNANDEZ. CRISTINA. Datos registrales. T 1476 , F 23, S 8, H TO 30264, I/A 12 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: ALONSO ALVAREZ BERNARDO. Datos registrales. T 1476 , F 23, S 8, H TO 30264, I/A 13 (16.07.09).
Nombramientos — 29/07/2009
Nombramientos. Apoderado: ALONSO RODRIGO ARTURO. Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 14 (16.07.09).
Revocaciones — 29/07/2009
Revocaciones. Apoderado: DEL CERRO IGLESIAS JULIO. Datos registrales. T 1476 , F 24, S 8, H TO 30264, I/A 15 (16.07.09).
Revocaciones — 23/06/2009
Revocaciones. Auditor: TEM AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1466 , F 68, S 8, H TO 30264, I/A 4 (10.06.09).