Actos destacados
Reelecciones — 12/09/2019
Reelecciones. Consejero: RUBIERA RUISANCHEZ PELAYO;RUBIERA RUISANCHEZ LUIS PEDRO;DIAZ IGLESIAS IGNACIO. Con.Delegado: RUBIERA RUISANCHEZ LUIS PEDRO. Presidente: RUBIERA RUISANCHEZ PELAYO. Secretario: RUBIERA RUISANCHEZ...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 21/12/2018
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: ABEYTUA GARCIA MARIA TERESA. Aud.Supl.: COBO VALERI FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Auditor: COBO VALERI FRANCISCO JAVIER. Aud.Supl.: REVENGA GOMEZ VICENTE. Datos regi...
Ampliación de capital — 06/10/2015
Ampliación de capital. Suscrito: 350.984,00 Euros. Desembolsado: 350.984,00 Euros. Resultante Suscrito: 675.524,00 Euros. Resultante Desembolsado: 675.524,00 Euros. Datos registrales. T 631, L 422, F 154, S 8, H BU 1677...
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 31/03/2015
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Exp.Ind.: GOMEZ RUIZ RAFAEL. Nombramientos. Auditor: ABEYTUA GARCIA MARIA TERESA. Aud.Supl.: COBO VALERI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 631, L 422, F 153, S 8, H BU 1677...
Ceses/dimisiones — 30/09/2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MENENDEZ GARCIA JOSE TORIBIO. Cons.Del.Sol: MENENDEZ GARCIA JOSE TORIBIO;RUBIERA RUISANCHEZ LUIS PEDRO. Presidente: RUBIERA RUISANCHEZ PELAYO. Secretario: RUBIERA RUISANCHEZ LUIS PEDRO. Nomb...
Nombramientos — 23/04/2014
Nombramientos. Auditor: ABEYTUA GARCIA MARIA TERESA. Datos registrales. T 631, L 422, F 152, S 8, H BU 1677, I/A 55 (15.04.14).
Revocaciones — 23/10/2013
Revocaciones. Auditor: ASTURAUDIMEBA SL. Datos registrales. T 631, L 422, F 152, S 8, H BU 1677, I/A 54 (17.10.13).
Ceses/dimisiones — 20/08/2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VIDAL APARICIO DANIEL. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 53 (13.08.13).
Cancelaciones de oficio de nombramientos — 24/04/2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Aud.Supl.: GARCIA CIPITRIA IGNACIO. Nombramientos. Auditor: ASTURAUDIMEBA SL. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A...
Reelecciones — 16/10/2012
Reelecciones. Auditor: GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Aud.Supl.: GARCIA CIPITRIA IGNACIO. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 51 ( 5.10.12). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANT...
Ceses/dimisiones — 22/12/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ PAREDES FERMIN. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 50 (13.12.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 241 Jueves 22 de diciembre de 2011 Pág. 71518 c...
Reelecciones — 26/09/2011
Reelecciones. Auditor: GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Aud.Supl.: GARCIA CIPITRIA IGNACIO. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 49 (15.09.11).
Cambio de domicilio social — 31/08/2011
Cambio de domicilio social. CTRA CL-629 BURGOS-VILLARCAYO Km 12 (QUINTANAORTUÑO). Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 48 (23.08.11).
Ceses/dimisiones — 05/05/2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: JUNQUERA MONTERO JOSE DIEGO. Nombramientos. Consejero: DIAZ IGLESIAS IGNACIO. Datos registrales. T 631, L 422, F 151, S 8, H BU 1677, I/A 47 (25.04.11).
Ceses/dimisiones — 28/07/2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: TARANCON ANTUÑA JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: VIDAL APARICIO DANIEL. Datos registrales. T 491, L 282, F 157, S 8, H BU 1677, I/A 46 (19.07.10).
Reelecciones — 25/06/2010
Reelecciones. Auditor: GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Aud.Supl.: GARCIA CIPITRIA IGNACIO. Datos registrales. T 491, L 282, F 157, S 8, H BU 1677, I/A 45 (17.06.10).
Nombramientos — 23/09/2009
Nombramientos. Aud.Supl.: GARCIA CIPITRIA IGNACIO. Reelecciones. Auditor: GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS. Datos registrales. T 491, L 282, F 157, S 8, H BU 1677, I/A 44 (15.09.09).