Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 12 tarjetas
21/06/2017 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-257831

Reelecciones — 21/06/2017

Reelecciones. Adm. Unico: ALONSO GONZALEZ OSCAR. Datos registrales. T 2075, L 2075, F 217, S 8, H PO 4563, I/A 45 (13.06.17).

01/02/2017 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-52489

Nombramientos — 01/02/2017

Nombramientos. Apoderado: MIÑAN LOPEZ FLORIANO. Datos registrales. T 2075, L 2075, F 217, S 8, H PO 4563, I/A 44 (24.01.17).

19/01/2016 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-20544

Nombramientos — 19/01/2016

Nombramientos. Apoderado: ALONSO GONZALEZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 55, S 8, H PO 4563, I/A 43 (11.01.16).

13/05/2013 Sec. I Cancelaciones de oficio de nombramientos Pontevedra
Pontevedra-218786

Cancelaciones de oficio de nombramientos — 13/05/2013

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Aud.Supl.: MARTIN SARACHO ALEJANDRO. Auditor: AUDITORIA TECNICA CONTABLE SL. Nombramientos. Auditor: EUDITA-AUDITEC TECNICOS AUDITORES SOC...

18/01/2012 Sec. I Reelecciones Pontevedra
Pontevedra-23624

Reelecciones — 18/01/2012

Reelecciones. Auditor: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Aud.Supl.: MARTIN SARACHO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 54, S 8, H PO 4563, I/A 40 ( 5.01.12).

23/12/2011 Sec. I Declaración de unipersonalidad Pontevedra
Pontevedra-513472

Declaración de unipersonalidad — 23/12/2011

Declaración de unipersonalidad. Socio único: GRUPO A G HOLDING FINANCIERO SL. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 54, S 8, H PO 4563, I/A 39 (12.12.11).

01/06/2011 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-234634

Ceses/dimisiones — 01/06/2011

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO GONZALEZ CELSO;ALONSO GONZALEZ OSCAR;GONZALEZ BARREIRO DARITA;CARPIO PIMENTEL ANTONIO. Presidente: ALONSO GONZALEZ CELSO. Secretario: CARPIO PIMENTEL ANTONIO. Cons.Del.Sol: ALONSO GON...

01/06/2011 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-234635

Nombramientos — 01/06/2011

Nombramientos. Apoderado: ALONSO GONZALEZ CELSO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 54, S 8, H PO 4563, I/A 38 (19.05.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 104 Miércoles 1 de junio de 2011 Pág. 27956 cve: B...

11/02/2010 Sec. I Reducción de capital Pontevedra
Pontevedra-60048

Reducción de capital — 11/02/2010

Reducción de capital. Importe reducción: 151.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 750.000,00 Euros. Escisión parcial. Sociedades beneficiarias de la escisión: GRUPO A G HOLDING FINANCIERO SL. Datos registrales. T 1153, L...

06/10/2009 Sec. I Revocaciones Pontevedra
Pontevedra-420434

Revocaciones — 06/10/2009

Revocaciones. Apo.Manc.: MIÑAN LOPEZ FLORIANO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 51, S 8, H PO 4563, I/A 35 (24.09.09).

02/09/2009 Sec. I Nombramientos Pontevedra
Pontevedra-380983

Nombramientos — 02/09/2009

Nombramientos. Auditor: GONZALEZ CRESPAN JUAN MANUEL. Aud.Supl.: MARTIN SARACHO ALEJANDRO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 50, S 8, H PO 4563, I/A 34 (19.08.09).

20/08/2009 Sec. I Ceses/Dimisiones Pontevedra
Pontevedra-364537

Ceses/dimisiones — 20/08/2009

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: ALONSO GONZALEZ CELSO;ALONSO GONZALEZ OSCAR. Nombramientos. Cons.Del.Sol: ALONSO GONZALEZ OSCAR;ALONSO GONZALEZ CELSO. Datos registrales. T 1153, L 1153, F 50, S 8, H PO 4563, I/A 33 ( 6....