Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2017 5 tarjetas
25/09/2017 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-381391

Nombramientos — 25/09/2017

Nombramientos. APODERAD.SOL: SOLER PALAU JORGE. Datos registrales. T 44672 , F 2, S 8, H B 288291, I/A 20 (18.09.17).

30/11/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-484288

Revocaciones — 30/11/2016

Revocaciones. APODERADO: LOPEZ SERENTILL ESTHER;LOPEZ SERENTILL ESTHER. Datos registrales. T 44672 , F 1, S 8, H B 288291, I/A 18 (21.11.16). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 228 Miércoles 30 de noviembre de...

30/11/2016 Sec. I Nombramientos Barcelona
Barcelona-484289

Nombramientos — 30/11/2016

Nombramientos. APODERAD.SOL: LOPEZ SERENTILL ESTHER. Datos registrales. T 44672 , F 2, S 8, H B 288291, I/A 19 (21.11.16).

17/11/2016 Sec. I Revocaciones Barcelona
Barcelona-464700

Revocaciones — 17/11/2016

Revocaciones. ADMINISTR.: LOPEZ SERENTILL ESTHER. Nombramientos. ADM.UNICO: LOPEZ DOMENECH FERNANDO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE...

27/11/2015 Sec. I Reducción de capital Barcelona
Barcelona-481568

Reducción de capital — 27/11/2015

Reducción de capital. Importe reducción: 11.076.765,29 Euros. Resultante Suscrito: 2.997.904,71 Euros. Datos registrales. T 44672 , F 1, S 8, H B 288291, I/A 16 (19.11.15).