Actos destacados
Ceses/dimisiones — 19/03/2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración:...
Revocaciones — 27/02/2018
Revocaciones. Apoderado: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Sol.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Apo.Manc.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME. Nombramientos. Apo.Sol.: OLEA AVILES JOSE MANUEL. Dato...
Ceses/dimisiones — 07/12/2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SPV SPAIN 5 SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a...
Nombramientos — 07/12/2016
Nombramientos. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 17 (29.11.16).
Cambio de domicilio social — 25/02/2016
Cambio de domicilio social. AVDA PICASSENT 10 - EDIFICIO A, 02600 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 964, L 728, F 107, S 8, H AB 17972, I/A 15 (18.02.16).
Revocaciones — 01/02/2016
Revocaciones. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Apo.Man.Soli: SANMARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ...
Ceses/dimisiones — 21/10/2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 11 (13.10.14).
Ceses/dimisiones — 13/05/2014
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO. Nombramientos. Adm. Solid.: GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;ORTEGA MARTINEZ JUAN DOMINGO;ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Modificaciones estatutarias. Cambio del Org...
Cambio de domicilio social — 03/02/2014
Cambio de domicilio social. AVDA DE LOS REYES CATOLICOS 151 (VILLARROBLEDO). Datos registrales. T 940, L 704, F 66, S 8, H AB 17972, I/A 9 (24.01.14).
Nombramientos — 30/01/2014
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA MARTINEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 925, L 689, F 3, S 8, H AB 17972, I/A 7 (22.01.14).
Revocaciones — 03/01/2013
Revocaciones. Apoderado: CALERO BRAZALEZ JUAN JOSE. Datos registrales. T 900, L 664, F 172, S 8, H AB 17972, I/A 6 (15.12.12).
Ampliación de capital — 19/12/2012
Ampliación de capital. Capital: 5.300.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.303.006,00 Euros. Datos registrales. T 900, L 664, F 172, S 8, H AB 17972, I/A 7 (12.12.12).
Fusión por absorción — 10/11/2010
Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: PAGO DE JUAN AGUSTIN SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 896, L 660, F 144, S 8, H AB 17972, I/A 5 (29.10.10).
Nombramientos — 14/06/2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAN MARTIN DE CASTRO JUAN CARLOS;GALOBART SANCHEZ MARCO JAIME;OLEA AVILES JOSE MANUEL. Apo.Sol.: GIL ACACIO MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 867, L 631, F 46, S 8, H AB 17972, I/A 4 ( 2...