Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 5 tarjetas
02/09/2019 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-376738

Ceses/dimisiones — 02/09/2019

Ceses/Dimisiones. Secretario: GARAYGORDOBIL AMORRORTU FRANCISCO. Cons.Del.Man: GARAYGORDOBIL AMORRORTU FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES SL. Secretario: IBAIZABAL MANAGEMENT SERVICES SL....

20/12/2017 Sec. I Ceses/Dimisiones A Coruña
A Coruña-496610

Ceses/dimisiones — 20/12/2017

Ceses/Dimisiones. Consejero: ESCUDERO ZAVALA PEDRO. Presidente: ESCUDERO ZAVALA PEDRO. Cons.Del.Man: ESCUDERO ZAVALA PEDRO. Revocaciones. Apo.Manc.: PORTO FERNANDEZ ANGEL MANUEL;CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR;BOADO LIEBING GU...

29/02/2016 Sec. I Revocaciones A Coruña
A Coruña-90721

Revocaciones — 29/02/2016

Revocaciones. Apo.Manc.: PORTO FERNANDEZ ANGEL MANUEL;FERNANDEZ PEINADO CARLOS ARTURO;BOADO LIEBING GUSTAVO JAVIER. Nombramientos. Apo.Manc.: PORTO FERNANDEZ ANGEL MANUEL;CHAO LOPEZ MARIA DEL MAR;BOADO LIEBING GUSTAVO J...

07/03/2014 Sec. I Constitución A Coruña
A Coruña-105895

Constitución — 07/03/2014

Constitución. Comienzo de operaciones: 24.02.14. Objeto social: Explotación de toda clase de buques, embarcaciones y artefactos flotantes. Explotación de buques remolcadores. Domicilio: CTRA ALTA DEL PUERTO Km Bl.1 BAJO...

07/03/2014 Sec. I Nombramientos A Coruña
A Coruña-105896

Nombramientos — 07/03/2014

Nombramientos. Apo.Manc.: PORTO FERNANDEZ ANGEL MANUEL;FERNANDEZ PEINADO CARLOS ARTURO;BOADO LIEBING GUSTAVO JAVIER. Datos registrales. T 3509 , F 140, S 8, H C 51083, I/A 2 (28.02.14).