Actos destacados
Nombramientos — 20/01/2026
Nombramientos. Apo.Man.Soli: EVA OLAVARRIETA BERNARDINO. Datos registrales. S 8 , H MU 60855, I/A 34 (12.01.26).
Nombramientos — 15/03/2018
Nombramientos. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datos registrales. T 3196 , F 128, S 8, H MU 60855, I/A 22 ( 8.03.18).
Nombramientos — 15/03/2018
Nombramientos. Apoderado: RAUL BORREGUERO MARTIN. Datos registrales. T 3196 , F 128, S 8, H MU 60855, I/A 23 ( 8.03.18).
Nombramientos — 15/09/2017
Nombramientos. Apo.Sol.: ANDRES JOSE AYALA SANCHEZ;JUAN JOSE FANLO GOMEZ. Datos registrales. T 3196 , F 127, S 8, H MU 60855, I/A 21 ( 8.09.17).
Nombramientos — 19/07/2017
Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3196 , F 127, S 8, H MU 60855, I/A 20 (12.07.17).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Datos registrales. T 2840 , F 170, S 8, H MU 60855, I/A 14 ( 6.09.16).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: LORENZO IGNACIO GUERRA FAGALDE. Datos registrales. T 3196 , F 122, S 8, H MU 60855, I/A 15 ( 6.09.16).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: RODOLFO BASTIDA CARO. Datos registrales. T 3196 , F 122, S 8, H MU 60855, I/A 16 ( 6.09.16).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: MARIA DEL CARMEN GINE DOMINGUEZ. Datos registrales. T 3196 , F 127, S 8, H MU 60855, I/A 17 ( 6.09.16).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ. Datos registrales. T 3196 , F 127, S 8, H MU 60855, I/A 18 ( 6.09.16).
Nombramientos — 13/09/2016
Nombramientos. Apoderado: QUERUBINA HERNANDEZ VIVANCOS. Datos registrales. T 3196 , F 127, S 8, H MU 60855, I/A 19 ( 6.09.16).
Nombramientos — 11/12/2014
Nombramientos. Apoderado: JUAN JOSE GALINDO BROCAL. Datos registrales. T 2840 , F 170, S 8, H MU 60855, I/A 13 ( 3.12.14).
Otros conceptos: se modifica la redacción del último párrafo del artículo 9ºde los estatutos sociales — 09/04/2013
Otros conceptos: Se modifica la redacción del último párrafo del artículo 9ºde los Estatutos sociales. Datos registrales. T 2840 , F 170, S 8, H MU 60855, I/A 12 ( 3.04.13).
Cambio de domicilio social — 08/01/2013
Cambio de domicilio social. C/ SILICIO10 - POLIGONO INDUSTRIAL LOS CAMACHOS (CARTAGENA). Datos registrales. T 2840 , F 170, S 8, H MU 60855, I/A 10 (27.12.12).
Ampliación de capital — 08/01/2013
Ampliación de capital. Capital: 29.669,00 Euros. Resultante Suscrito: 43.667.664,00 Euros. Datos registrales. T 2840 , F 170, S 8, H MU 60855, I/A 11 (27.12.12).
Ceses/dimisiones — 10/08/2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: EMILIO RESTOY ZAMORA. Presidente: EMILIO RESTOY ZAMORA. Consejero: EMILIO RESTOY CABRERA;RODOLFO BASTIDA CARO;CARLOS MATEO PEREZ LLORENTE. Secretario: CARLOS MATEO PEREZ LLORENTE. Consejero:...
Pérdida del caracter de unipersonalidad — 17/11/2011
Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 43.627.995,00 Euros. Resultante Suscrito: 43.637.995,00 Euros. Datos registrales. T 2840 , F 169, S 8, H MU 60855, I/A 8 ( 8.11.11).
Nombramientos — 10/11/2011
Nombramientos. Apoderado: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ. Apo.Manc.: ENRIQUE DE COIG O`DONNELL LOPEZ;MARIA DEL CARMEN VALLEJO SANCHEZ. Datos registrales. T 2422 , F 71, S 8, H MU 60855, I/A 7 (31.10.11).
Revocaciones — 07/03/2011
Revocaciones. Apo.Sol.: EMILIO RESTOY ZAMORA. Datos registrales. T 2422 , F 71, S 8, H MU 60855, I/A 6 (24.02.11). BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 45 Lunes 7 de marzo de 2011 Pág. 12452 cve: BORME-A-2011-45-...
Nombramientos — 10/01/2011
Nombramientos. Consejero: EMILIO RESTOY CABRERA;RODOLFO BASTIDA CARO. Datos registrales. T 2422 , F 71, S 8, H MU 60855, I/A 5 (29.12.10).