Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2019 4 tarjetas
01/02/2019 Sec. I Cambio de domicilio social Zaragoza
Zaragoza-48508

Cambio de domicilio social — 01/02/2019

Cambio de domicilio social. CTRA DE CASTELLON, POLIGONO SAN VALERO - NAVE 3 (ZARAGOZA). Datos registrales. T 3246 , F 170, S 8, H Z 29442, I/A 11 (25.01.19).

09/10/2018 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-406564

Ceses/dimisiones — 09/10/2018

Ceses/Dimisiones. R.L.C.Perma.: LOOSE MANFRED GEORG. Nombramientos. Apoderado: RAY STEVEN FRANK. R.L.C.Perma.: RAY STEVEN FRANK. Datos registrales. T 3246 , F 170, S 8, H Z 29442, I/A 10 ( 3.10.18).

25/11/2015 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-477962

Nombramientos — 25/11/2015

Nombramientos. Apo.Sol.: SHARPE CHARLES EDWARD;KESSEL MARKUS. Datos registrales. T 3246 , F 169, S 8, H Z 29442, I/A 9 (18.11.15).

20/03/2015 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-120469

Ceses/dimisiones — 20/03/2015

Ceses/Dimisiones. R.L.C.Perma.: LODS FRANCOIS WILIAM. Nombramientos. R.L.C.Perma.: LOOSE MANFRED GEORG. Datos registrales. T 3246 , F 169, S 8, H Z 29442, I/A 8 (10.03.15).