Actos destacados

Se muestran los eventos mas recientes incluidos en el reporte compactado.

Ultimo ano visible 2016 12 tarjetas
03/10/2016 Sec. I Disolución Zaragoza
Zaragoza-398551

Disolución — 03/10/2016

Disolución. Fusion. Extinción. Datos registrales. T 4000 , F 220, S 8, H Z 25299, I/A C (23.09.16). http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958

19/07/2016 Sec. I Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE 6 MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO Zaragoza
Zaragoza-301012

Otros conceptos: cerrada la hoja por plazo provisional de 6 meses, conforme al articulo 231 del reglamento — 19/07/2016

Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE 6 MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO. Datos registrales. T 4000 , F 220, S 8, H Z 25299, I/A 29 N (11.07.16).

19/03/2014 Sec. I Revocaciones Zaragoza
Zaragoza-125421

Revocaciones — 19/03/2014

Revocaciones. Apoderado: EGIDO SOLER ISIDRO ALBERTO. Datos registrales. T 4000 , F 220, S 8, H Z 25299, I/A 29 (11.03.14).

27/11/2013 Sec. I Ceses/Dimisiones Zaragoza
Zaragoza-507126

Ceses/dimisiones — 27/11/2013

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Unico: JIMENEZ SAN MARTIN FRANCISCO. Datos registrales. T 3242 , F 125, S 8, H Z 25299, I/A 28 (19.11.13).

16/07/2013 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-321439

Nombramientos — 16/07/2013

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ CHACON MIGUEL-ANGEL. Datos registrales. T 3242 , F 125, S 8, H Z 25299, I/A 27 ( 4.07.13).

19/04/2011 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-174689

Nombramientos — 19/04/2011

Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ OCAÑA MANUEL JESUS. Datos registrales. T 3242 , F 125, S 8, H Z 25299, I/A 26 ( 8.04.11).

14/02/2011 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-67067

Reelecciones — 14/02/2011

Reelecciones. Auditor: FGV AUDITORES Y CONSULTORES SLP. Datos registrales. T 3242 , F 125, S 8, H Z 25299, I/A 25 ( 3.02.11).

11/06/2010 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-233575

Nombramientos — 11/06/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTEGA VERDUGO FRANCISCO JAVIER;ROMERO REYES JOSE MANUEL. Datos registrales. T 3242 , F 124, S 8, H Z 25299, I/A 24 ( 1.06.10).

05/04/2010 Sec. I Ampliación de capital Zaragoza
Zaragoza-136810

Ampliación de capital — 05/04/2010

Ampliación de capital. Suscrito: 688.600,00 Euros. Desembolsado: 688.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.078.600,00 Euros. Resultante Desembolsado: 1.078.600,00 Euros. Datos registrales. T 3242 , F 124, S 8, H Z 25299,...

09/03/2010 Sec. I Nombramientos Zaragoza
Zaragoza-100277

Nombramientos — 09/03/2010

Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ SAN MARTIN FRANCISCO;JIMENEZ SANMARTIN CARMEN. Datos registrales. T 3242 , F 124, S 8, H Z 25299, I/A 22 (26.02.10).

15/06/2009 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-269524

Reelecciones — 15/06/2009

Reelecciones. Adm. Unico: JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Datos registrales. T 3242 , F 123, S 8, H Z 25299, I/A 20 ( 3.06.09).

10/02/2009 Sec. I Reelecciones Zaragoza
Zaragoza-73769

Reelecciones — 10/02/2009

Reelecciones. Auditor: FGV AUDITORES Y CONSULTORES SL. Datos registrales. T 3242 , F 123, S 8, H Z 25299, I/A 19 (28.01.09).